HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED

HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00697361
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    • Circoli con licenza (56301) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Azets Holdings Limited 5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Haberfield Old Moor Road Wennington Lancaster LA2 8PD a C/O Azets Holdings Limited 5th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU in data 10 giu 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 mag 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    12 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2016

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium reserve be cancelled 16/11/2015
    RES13

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2015

    Stato del capitale al 08 ott 2015

    • Capitale: GBP 1,068,914
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RIMMER, David Norman
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Newport Road
    ST21 6BE Eccleshall
    Ridgefield 23
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish71617270002
    WALKER, Jonathan James
    5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Azets Holdings Limited
    Amministratore
    5th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    C/O Azets Holdings Limited
    EnglandBritish39444010001
    HAWORTH, Ralph Thomas
    15 Kingswood Place
    NN18 9AF Corby
    Northamptonshire
    Segretario
    15 Kingswood Place
    NN18 9AF Corby
    Northamptonshire
    British76547080001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Segretario
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    British110216340001
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Segretario
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    British134403640001
    SMITH, Terrence Kevin
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    British30640310001
    BREATHWICK, Leslie
    The Old Farmhouse Mayns Lane
    Burton Overy
    LE8 9DP Leicester
    Amministratore
    The Old Farmhouse Mayns Lane
    Burton Overy
    LE8 9DP Leicester
    British41606000003
    CUNNINGHAM, William Andrew
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    4 Goodwood Rise
    CW10 9FJ Middlewich
    Cheshire
    EnglandBritish113656620001
    DOBSON, Stephen
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    Amministratore
    24 Parklands Drive
    Weston
    CW2 5FH Crewe
    United KingdomBritish127852340001
    HAMBLIN, Betty
    40 Woodland Road
    NN10 6UT Rushden
    Northamptonshire
    Amministratore
    40 Woodland Road
    NN10 6UT Rushden
    Northamptonshire
    British30393110001
    HAMBLIN, Jonathan Robert
    The Old School House 1 Carlton Road
    Wilbarston
    LE16 8QD Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old School House 1 Carlton Road
    Wilbarston
    LE16 8QD Market Harborough
    Leicestershire
    British4838310001
    HAMBLIN, June Anne
    12 Bramble Close
    Uppingham
    LE15 9PH Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    12 Bramble Close
    Uppingham
    LE15 9PH Oakham
    Leicestershire
    British30859200003
    HAMBLIN, Margaret Elizabeth
    5 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Carisbrooke Road
    Mountsorrel
    LE12 7BR Loughborough
    Leicestershire
    British30859180002
    HAMBLIN, Peter Richard
    Heath House
    Luffenham Ketton
    PE9 3UU Stamford
    Lincs
    Amministratore
    Heath House
    Luffenham Ketton
    PE9 3UU Stamford
    Lincs
    United KingdomBritish34415070005
    HAMBLIN, Peter Robert
    The Barns
    Main Street Gumley
    LE16 7RU Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Barns
    Main Street Gumley
    LE16 7RU Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish49238070003
    HAMBLIN, Samantha Caroline
    Foster's Bridge
    Ketton
    PE9 3BF Stamford
    Heath Cottage
    Rutland
    Amministratore
    Foster's Bridge
    Ketton
    PE9 3BF Stamford
    Heath Cottage
    Rutland
    United KingdomBritish67760670002
    HAWORTH, Ralph Thomas
    15 Kingswood Place
    NN18 9AF Corby
    Northamptonshire
    Amministratore
    15 Kingswood Place
    NN18 9AF Corby
    Northamptonshire
    British76547080001
    HTIBLIN, Andron David
    3 Kings Meadow Lane
    Higham Ferrers
    NN10 8JE Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Kings Meadow Lane
    Higham Ferrers
    NN10 8JE Wellingborough
    Northamptonshire
    British30859230001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish110216340001
    PEARSON, Andrew Guy
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    Amministratore
    Ladyhill View
    Worsley
    M28 7LH Manchester
    42
    EnglandBritish134403640001
    PITCHER, Arthur Cuthbert
    14 Willow Lane
    Stanion
    NN14 1DT Kettering
    Northants
    Amministratore
    14 Willow Lane
    Stanion
    NN14 1DT Kettering
    Northants
    British35557490002
    SHAW, Anthony Brian
    18 Adelaide Road
    BR7 6BB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    18 Adelaide Road
    BR7 6BB Chislehurst
    Kent
    British31932630001
    SMITH, Terrence Kevin
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    46 Springfield Close
    Burton On The Wolds
    LE12 5AN Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish30640310001
    WALSH, Neil
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    Amministratore
    The Paddock
    Beardwood
    BB2 7QY Blackburn
    2
    Lancashire
    United KingdomBritish134469650001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Stardust Bingo Club Limited
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    Lancashire
    England
    06 apr 2016
    Old Moor Road
    Wennington
    LA2 8PD Lancaster
    Haberfield
    Lancashire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione04062910
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 12 mag 2006
    Consegnato il 22 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The stardust centre 82 george street corby northants t/no NN160090 and NN231117.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 22 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mag 2006
    Consegnato il 22 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The stardust centre 82 george street corby northants t/no NN160090 and NN231117. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 22 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The second advance being £1,000,000 due under the terms of the loan agreement and all other monies due or to become due from the company and/or any or all of the other companies named therin to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leslie Breathwick
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party charge of debt
    Creato il 12 ott 1994
    Consegnato il 18 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stardust (kettering) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £33,000 due from stardust (kettering) limited inc, all interest accrued.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 12 lug 1993
    Consegnato il 29 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £236,961.66 from the company and/or first hamblin limited to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its rights title and interest in and to all sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 29 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 lug 1989
    Consegnato il 12 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H corby bowling alley and offices known as the stardust centre, george street,corby, northampton and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 lug 1989
    Consegnato il 12 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H rutland theatre (formerly known as the odean cinema) rockingham road corby northamptonshire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 giu 1989
    Consegnato il 04 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 feb 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 10 lug 1986
    Consegnato il 18 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 ago 1985
    Consegnato il 16 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The spread eagle, oakley road, corby, northants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 ott 1984
    Consegnato il 23 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings bruce grove cinema bruce grove, tottenham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1982
    Consegnato il 19 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the corby bowling alley & offices nos 82 & 86 george street corby northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 19 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 mag 1982
    Consegnato il 14 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fh the odeon cinema, corby, northants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 mag 1982
    Consegnato il 14 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F h land and buildings on south side of russell street, kettering, northants known as "the savoy" title no nn 50420.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 mag 1982
    Consegnato il 14 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F.H. 222 kettering road and 2 abington avenue, northampton, northants. Title no nn 23491.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 apr 1982
    Consegnato il 15 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings,fixtures,fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1982Registrazione di un'ipoteca

    HAMBLINS LEISURE SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 mag 2022Inizio della liquidazione
    07 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicola Clark
    Azets Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    Azets Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Jonathan Amor
    Azets, 5th Floor Ship Canal House, 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    England
    Praticante
    Azets, 5th Floor Ship Canal House, 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    England

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0