DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED

DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDOUGLAS EQUIPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00697744
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    • fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali e relative macchine (30300) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ML DOUGLAS EQUIPMENT LTD22 lug 198822 lug 1988
    F.L. DOUGLAS (EQUIPMENT) LIMITED10 lug 196110 lug 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2015

    Stato del capitale al 07 gen 2015

    • Capitale: GBP 16,162,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 gen 2014

    Stato del capitale al 03 gen 2014

    • Capitale: GBP 16,162,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2013

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di David Weil come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Johnson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    20 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Matthew Philip Johnson come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Douglas House, Village Road Cheltenham Gloucestershire GL51 0AB* in data 23 mag 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Lee Brewis come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Mr John Richard Duffy come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Robert Stephen Towill come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per David Frederick Weil il 02 gen 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TOWILL, Robert Stephen
    Bumblebees
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Bumblebees
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishAccountant86728020001
    DUFFY, John Richard
    c/o 35th Floor
    3 Sheung Yuet Road
    Kowloon
    Enterprise Square Two
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    c/o 35th Floor
    3 Sheung Yuet Road
    Kowloon
    Enterprise Square Two
    Hong Kong
    Hong Kong
    Hong KongBritishDirector149894980001
    TOWILL, Robert Stephen
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant86728020001
    BREWIS, Carolyn Julie
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSecretary84647400002
    COLEMAN, Christopher John
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant91487190001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    BritishAccountant36711070001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Segretario
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    BritishAccountant36711070001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    British2641580001
    SIMS, Robin Edward
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    57 Kings Road
    KT12 2RB Walton On Thames
    Surrey
    British52343580001
    WALLIS, Robert Charles Hedley
    1 Glebe Field
    Almondsbury
    BS32 4DL Bristol
    Glocestershire
    Segretario
    1 Glebe Field
    Almondsbury
    BS32 4DL Bristol
    Glocestershire
    British56610660001
    ATKINSON, Roger Scott
    The Flinthouse
    Pound Lane
    WR6 6EE Clifton On Teme
    Worcester
    Amministratore
    The Flinthouse
    Pound Lane
    WR6 6EE Clifton On Teme
    Worcester
    United KingdomBritishCompany Director82851270001
    BENJAMIN, John
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director75927710002
    BREWIS, Carolyn Julie
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    86 Century Court
    Montpellier Grove
    GL50 2XR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSecretary84647400002
    BREWIS, Lee Alexander
    The Bothy Rushley Lane
    Winchcombe
    GL54 5JE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Bothy Rushley Lane
    Winchcombe
    GL54 5JE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandAustralianManaging Director84653460003
    BROWN, William Francis
    7 Oaken Drive
    B91 1RJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    7 Oaken Drive
    B91 1RJ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director3716160001
    BRYANT, Michael John
    Oakwood Brake Lane
    West Hagley
    DY8 2XW Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Oakwood Brake Lane
    West Hagley
    DY8 2XW Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector61720130001
    BRYSON, John Macdonald
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Edgton Little Tangley
    Wonersh
    GU5 0PW Guildford
    Surrey
    BritishGroup Finance Director10076550001
    BURTON, Stephen Leslie
    Lynton House
    Queens Drive,
    CV35 7DA Rowington
    Warwick
    Amministratore
    Lynton House
    Queens Drive,
    CV35 7DA Rowington
    Warwick
    BritishDirector71989770001
    CALLOW, John William
    1 Fairhurst Drive
    CV32 6HX Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Fairhurst Drive
    CV32 6HX Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector51889810001
    COLEMAN, Christopher John
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 Lypiatt Street
    GL50 2UA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant91487190001
    DOANE, Michael John
    24 Timperley Way
    Upper Hatherley
    GL51 5RH Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    24 Timperley Way
    Upper Hatherley
    GL51 5RH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director22589290001
    DUNN, John Michael
    17 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    17 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director3716190001
    FLEMING, John
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    Amministratore
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    BritishCompany Director107749800001
    GARDINER, Anthony Martin
    7 Churchill Gate
    OX20 1QW Woodstock
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Churchill Gate
    OX20 1QW Woodstock
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant/Finance Director39207890001
    GEARY, Patrick Brendan
    3 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2SN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    3 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2SN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector80957730001
    HAUGHTON, Adrian Paul
    Barn Cottage Grimers Farm
    Pendock Road
    GL19 3LG Redmarley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Barn Cottage Grimers Farm
    Pendock Road
    GL19 3LG Redmarley
    Gloucestershire
    BritishCompany Director50089840001
    HENFREY, Anthony William, Dr
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    Amministratore
    7 The Vat House
    Regents Bridge Gardens
    SW8 1HD London
    EnglandBritishCompany Director42207200001
    HICKS, Frank
    The Old Dairy Park Lane
    Swalcliffe
    OX15 5EU Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Dairy Park Lane
    Swalcliffe
    OX15 5EU Banbury
    Oxfordshire
    BritishCompany Director23572310001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector36711070001
    JACKSON, Robert Anthony
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    1 Dovecote Road
    WR9 7RN Droitwich
    Worcestershire
    United KingdomBritishAccountant36711070001
    JOHNSON, Matthew Philip
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Pullman Court
    Great Western Road
    GL1 3ND Gloucester
    5
    United Kingdom
    Hong KongBritishAccountant160346740001
    LOVERIDGE, James Douglas
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    10 Redding Drive
    HP6 5PX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSolicitor2641580001
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    BritishCompany Director7677600002
    PICKERING, Ian
    Avenue House The Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8HH Milton Keynes
    Bedfordshire
    Amministratore
    Avenue House The Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8HH Milton Keynes
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector3014270002
    PLANT, Nigel Andrew
    2 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    2 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishEngineering Director100058440001

    DOUGLAS EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 13 dic 2006
    Consegnato il 15 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Douglas house village road cheltenham glos t/no GR146878. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 15 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 11 giu 2003
    Consegnato il 12 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the west side of village road arle t/n GR146878. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 lug 1999
    Consegnato il 10 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    The freehold building 150 langar 11 industrial estate harby road langar rushcliff nottinghamshire title number NT210023 and land and buildings on the west side of village road arle cheltenham gloucestershire title number GR146878. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Agent and Trustee for the Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 10 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 08 giu 1993
    Consegnato il 15 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a guarantee and debenture dated 07/08/92
    Brevi particolari
    All that l/h property being premises at colndale road poyle middlesex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 ago 1992
    Consegnato il 17 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 set 1983
    Consegnato il 06 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or F.L. douglas holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0