KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED

KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00700656
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    • Fabbricazione di strumenti e forniture medico-chirurgiche (32500) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Belmont House
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    West Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MEDISCUS PRODUCTS LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    GEEVA ENGINEERING COMPANY LIMITED11 ago 196111 ago 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Stato del capitale al 05 lug 2022

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 01/07/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Irfan Mohammed Malik come amministratore in data 01 dic 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Jonathan Robert Lasparini come amministratore in data 01 dic 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simla Semerciyan come amministratore in data 01 dic 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Lars Hanseid come amministratore in data 01 dic 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di John Thomas Bibb come amministratore in data 11 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Patrick Panther come amministratore in data 11 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christiaan Jan Otto Pool come amministratore in data 11 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Simla Semerciyan come amministratore in data 11 ott 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Irfan Mohammed Malik come amministratore in data 11 ott 2019

    2 pagineAP01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRWIN MITCHELL SECRETARIES LIMITED
    Friary Lane
    PO19 1UF Chichester
    Thomas Eggar House
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    Friary Lane
    PO19 1UF Chichester
    Thomas Eggar House
    West Sussex
    United Kingdom
    37896530018
    HANSEID, Lars
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Amministratore
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomNorwegian275478440001
    LASPARINI, Jonathan Robert
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Amministratore
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomBritish270137030001
    DRAKE, Andrew Nicholas
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    Segretario
    61 Brook Street
    W1K 4BL London
    British48185570001
    HOLVEY, Michael Anthony John
    35 Pinewood Road
    BH22 9RP Ferndown
    Dorset
    Segretario
    35 Pinewood Road
    BH22 9RP Ferndown
    Dorset
    British125006650001
    LESAGE, Antoine
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Segretario
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Belgium107191470001
    NOLL, Dennis Edward
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    Segretario
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    American35805720003
    POLLINGTON, David
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Segretario
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    British6048410001
    WEHRMEYER, Robert
    29302 Grand Coteau
    FOREIGN Boerne
    Texas 78006
    Usa
    Segretario
    29302 Grand Coteau
    FOREIGN Boerne
    Texas 78006
    Usa
    American12499670001
    AVERSANO, Rudolph C
    101 William Street
    FOREIGN So Dartmouth
    Ma 02748
    Usa
    Amministratore
    101 William Street
    FOREIGN So Dartmouth
    Ma 02748
    Usa
    Usa6504120001
    BIBB, John Thomas
    Interstate 10 West
    78249 San Antonio
    12930
    Texas
    United States
    Amministratore
    Interstate 10 West
    78249 San Antonio
    12930
    Texas
    United States
    United StatesAmerican151052470001
    BURNS, William John David
    Langford Business Park
    Langford Locks Kidlington
    OX5 1GF Oxfordshire
    Kci House
    United Kingdom
    Amministratore
    Langford Business Park
    Langford Locks Kidlington
    OX5 1GF Oxfordshire
    Kci House
    United Kingdom
    United KingdomBritish129880280001
    CITO, Adriano
    1181le Amstelveen
    Van Heuven Goedhartlaan 11
    Netherlands
    Amministratore
    1181le Amstelveen
    Van Heuven Goedhartlaan 11
    Netherlands
    HungaryItalian149090240002
    DILAZZARO, Frank
    16203 Robinwood Lane
    San Antonio
    Texas 78248
    Usa
    Amministratore
    16203 Robinwood Lane
    San Antonio
    Texas 78248
    Usa
    Canadian12660610001
    HOLVEY, Michael
    34 Pinewood Road
    BH22 9RR Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    34 Pinewood Road
    BH22 9RR Ferndown
    Dorset
    British45788560002
    HOLVEY, Michael
    18 Darley Road
    BH22 8QX Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    18 Darley Road
    BH22 8QX Ferndown
    Dorset
    British45788560001
    HOWLING, Richard John
    20 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Amministratore
    20 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British40708600001
    HUNT, Kenneth William
    18 Egdon Drive
    BH21 1TY Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    18 Egdon Drive
    BH21 1TY Wimborne
    Dorset
    British58965530001
    JOYCE, Mick
    74 Dewlands Way
    BH31 6JN Verwood
    Dorset
    Amministratore
    74 Dewlands Way
    BH31 6JN Verwood
    Dorset
    British87063040001
    KASHYAP, Rohit Shrikant
    Kci House
    Langford Locks
    OX5 1GF Kidlington
    Kci Medical Limited
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kci House
    Langford Locks
    OX5 1GF Kidlington
    Kci Medical Limited
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican151052390001
    KUMAR, Tirunvelvchi Lakshmanaswamy Varadaraj
    Langley Road
    Merton Park
    SW19 3NZ London
    10
    Amministratore
    Langley Road
    Merton Park
    SW19 3NZ London
    10
    Indian129073450001
    LEININGER, James
    8023 Vantage Drive
    San Antonio Texas
    FOREIGN Usa
    Usa
    Amministratore
    8023 Vantage Drive
    San Antonio Texas
    FOREIGN Usa
    Usa
    American22327270002
    LESAGE, Antoine
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Amministratore
    De Croixlaan 2
    Berg
    1910
    Belgium
    Belgium107191470001
    MALIK, Irfan Mohammed
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomPakistani265894900001
    MATTHEWS, Michael Edward
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Amministratore
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    United KingdomAmerican172416940001
    MENTEN, Jorg Wilhelm
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    Amministratore
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    German109844500001
    MENTEN, Jorg Wilhelm
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    Amministratore
    Forggenstrasse 27
    Manneheim
    68279
    Germany
    German109844500001
    NOLL, Dennis Edward
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    Amministratore
    5 Birnam Oaks
    San Antonio
    Texas 78248
    U.S.A.
    American35805720003
    PANTHER, John Patrick
    4th Floor, One Kingdom Street
    Paddington Central
    W2 6BD London
    Kci Uk Holdings Ltd
    United Kingdom
    Amministratore
    4th Floor, One Kingdom Street
    Paddington Central
    W2 6BD London
    Kci Uk Holdings Ltd
    United Kingdom
    EnglandAmerican183237410001
    PEREZ, Arthur Alejandro
    Noordlaan 32
    Bergen
    1861 Gn
    Netherlands
    Amministratore
    Noordlaan 32
    Bergen
    1861 Gn
    Netherlands
    United States135039390001
    POLLINGTON, David
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    Culmer 48 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    EnglandBritish6048410001
    POOL, Christiaan Jan Otto
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    Amministratore
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    West Sussex
    NetherlandsDutch206646900001
    SEIDEL, Stephen Dale
    Vantage Dr.
    78230 San Antonio
    8023
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Vantage Dr.
    78230 San Antonio
    8023
    Texas
    Usa
    UsaUs166457690001
    SEIDEL, Stephen Dale
    214 Charles Road
    San Antonio
    Tx 78209
    Usa
    Amministratore
    214 Charles Road
    San Antonio
    Tx 78209
    Usa
    UsaUs166457690001
    SEMERCIYAN, Simla
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centre
    Cain Road
    RG12 8HT Bracknell
    3m
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomTurkish246637820002

    Chi sono le persone con controllo significativo di KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Kci Medical Limited
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    England
    06 apr 2016
    Station Way
    RH10 1JA Crawley
    Belmont House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione01130981
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    KCI MEDICAL PRODUCTS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 05 lug 2012
    Consegnato il 17 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All amounts now and in the future credited to account number 90290569 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 mar 1990
    Consegnato il 17 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge on all book & othe leets owing to the company. Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital (excluding those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    Assignment
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to nat west investment bank limited hambros bank limited and ensign trust PLC under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and on overdraft facility letter dated 1/5/87
    Brevi particolari
    Assigns to the cender all the rights, titles, bnefits and in terests of the company in the facility letters issued by the company on 1/5/87 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    • Ensign Trust PLC
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to nat west investment bank limited hambros bank limited and ensign trust PLC under te terms of a loan agrement dated 24/4/87 and the overdroft facility letter dated 1/5/87 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All dividends or interest paid on the entire issued & all otted stock of medisais products inc (the securities) (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Investment Bank Limited
    • Ensign Trust PLC
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Ensign Trust PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement datee 24/4/87 and a facility letter dated 1/4/87 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Hambres Bank Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 20 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 24/4/87 and under the terms of the chargee
    Brevi particolari
    4 units known as 10 westminster road wareham, dorset a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Nat West Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 08 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Guarnatee & debenture
    Creato il 18 gen 1980
    Consegnato il 25 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0