WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED

WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00702778
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    • Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
    • Raccolta di rifiuti pericolosi (38120) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica

    Dove si trova WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD in data 26 lug 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr John Sullivan come segretario in data 21 lug 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 21 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 21 lug 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Terence Sullivan come amministratore in data 21 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Cox come amministratore in data 21 lug 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 007027780013 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2016

    Stato del capitale al 26 mag 2016

    • Capitale: GBP 3,265
    SH01

    Nomina di Ms Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 01 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Sophie Catherine Jane Reed come segretario in data 01 apr 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter Anton Gerstrom come amministratore in data 01 dic 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 01 dic 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Chi sono gli amministratori di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Segretario
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210822090001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Amministratore
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    207872410001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189290260001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176235070001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Segretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198173670001
    ROBERTS, Michael William
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    Segretario
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    British3145950001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Amministratore
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritish105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritish138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Amministratore
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish556710002
    ROBERTS, Michael William
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    Amministratore
    10 Larkfield Close
    Greenmount
    BL8 4QJ Bury
    Lancashire
    EnglandBritish3145950001
    ROBERTS, Richard John
    24 Deacon Crescent
    BL8 3DW Bury
    Lancashire
    Amministratore
    24 Deacon Crescent
    BL8 3DW Bury
    Lancashire
    British49437130001
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish45141530001
    TAYLOR, James
    4 Rivershill Drive
    OL10 3BJ Heywood
    Lancashire
    Amministratore
    4 Rivershill Drive
    OL10 3BJ Heywood
    Lancashire
    British11374050001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Amministratore
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish57775660003
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish92108930002

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Waste Hire Services Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06 apr 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Uk
    Numero di registrazione3441128
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2015
    Consegnato il 27 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental common debenture
    Creato il 29 nov 2011
    Consegnato il 08 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 18 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 04 dic 1997
    Consegnato il 18 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 lug 1993
    Consegnato il 30 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the goodwill of the company.fixed charge over the property at whitelegge street,bury,lancashire BL8 1SW together with a floating charge over the undertaking and all property and assets including its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Mr Michael William Roberts
    Transazioni
    • 30 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 dic 1991
    Consegnato il 23 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 giu 1977
    Consegnato il 15 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the north east of bury greater manchester title no gm 35264.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1977
    Consegnato il 15 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land in spring vale street tottington greater manchester title no gm 93602.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1977
    Consegnato il 15 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the north east of bury road tottington bury greater manchester title no GM35264.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 1977
    Consegnato il 22 feb 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings in whitelegge st bury greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 1975
    Consegnato il 26 mar 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 whitelegge street bury greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 1975
    Consegnato il 26 mar 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on north west side of whitelegge street bury greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 17 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0