WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00702778 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
- Raccolta di rifiuti non pericolosi (38110) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
- Raccolta di rifiuti pericolosi (38120) / Captazione, depurazione e distribuzione di acqua; gestione dei rifiuti; attività di bonifica
Dove si trova WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD in data 26 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Sullivan come segretario in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Llewelyn Milnes-James come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alistair Myrie Holl come amministratore in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 21 lug 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr John Terence Sullivan come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Cox come amministratore in data 21 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 007027780013 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Ms Caroline Elizabeth Allen come segretario in data 01 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sophie Catherine Jane Reed come segretario in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Anton Gerstrom come amministratore in data 01 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles Nicholas Pollard come amministratore in data 01 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 9 pagine | MA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULLIVAN, John | Segretario | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210822090001 | |||||||
| COX, Paul Anthony | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 153797870001 | |||||
| SULLIVAN, John Terence | Amministratore | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 180046340001 | |||||
| ALLEN, Caroline Elizabeth | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 207872410001 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
| JESKE, Riga | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189290260001 | |||||||
| KAHVECI, Suheda | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176235070001 | |||||||
| PHILLIPS, Elizabeth Clare | Segretario | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
| REED, Sophie Catherine Jane | Segretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198173670001 | |||||||
| ROBERTS, Michael William | Segretario | 10 Larkfield Close Greenmount BL8 4QJ Bury Lancashire | British | 3145950001 | ||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Amministratore | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | 105363350001 | |||||
| GERSTROM, Peter Anton | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 138719750001 | |||||
| HARRISON, Julian John | Amministratore | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | 123927990001 | |||||
| HOLL, Alistair Myrie | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | 138014840001 | |||||
| JOHNSON, Peter Stuart | Amministratore | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | 11159620001 | |||||
| MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 140753960001 | |||||
| PHILLIPS, John | Amministratore | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 343070001 | ||||||
| POLLARD, Charles Nicholas | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 192011710001 | |||||
| RIDDLE, David Ellison | Amministratore | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | 556710002 | |||||
| ROBERTS, Michael William | Amministratore | 10 Larkfield Close Greenmount BL8 4QJ Bury Lancashire | England | British | 3145950001 | |||||
| ROBERTS, Richard John | Amministratore | 24 Deacon Crescent BL8 3DW Bury Lancashire | British | 49437130001 | ||||||
| STEGGLES, Jonathan David | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 45141530001 | |||||
| TAYLOR, James | Amministratore | 4 Rivershill Drive OL10 3BJ Heywood Lancashire | British | 11374050001 | ||||||
| WARD, Malcolm John | Amministratore | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 57775660003 | |||||
| WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Amministratore | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | 92108930002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Hire Services Limited | 06 apr 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
WILLIAM ROBERTS (HAULAGE) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 ago 2015 Consegnato il 27 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental common debenture | Creato il 29 nov 2011 Consegnato il 08 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession | Creato il 18 mag 2007 Consegnato il 25 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 apr 2005 Consegnato il 11 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 04 dic 1997 Consegnato il 18 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 lug 1993 Consegnato il 30 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over the goodwill of the company.fixed charge over the property at whitelegge street,bury,lancashire BL8 1SW together with a floating charge over the undertaking and all property and assets including its uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 dic 1991 Consegnato il 23 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 giu 1977 Consegnato il 15 giu 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and buildings lying to the north east of bury greater manchester title no gm 35264. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 26 mag 1977 Consegnato il 15 giu 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land in spring vale street tottington greater manchester title no gm 93602. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 26 mag 1977 Consegnato il 15 giu 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and buildings lying to the north east of bury road tottington bury greater manchester title no GM35264. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 feb 1977 Consegnato il 22 feb 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings in whitelegge st bury greater manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 mar 1975 Consegnato il 26 mar 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 11 whitelegge street bury greater manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 mar 1975 Consegnato il 26 mar 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings on north west side of whitelegge street bury greater manchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0