J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED

J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00704098
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 04 set 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 24/08/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Maurice Delon Jones il 14 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 14 mar 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURGESS, Richard Trevor
    6 Pleshey Close
    SS1 3SP Thorpe Bay
    Essex
    Segretario
    6 Pleshey Close
    SS1 3SP Thorpe Bay
    Essex
    British36253260001
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BURGESS, Richard Trevor
    6 Pleshey Close
    SS1 3SP Thorpe Bay
    Essex
    Amministratore
    6 Pleshey Close
    SS1 3SP Thorpe Bay
    Essex
    British36253260001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Amministratore
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Amministratore delegato nominato
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    WILTSHIRE, Harold Phillip
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    Amministratore
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    British930220001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 feb 1992
    Consegnato il 25 feb 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due under the terms of an underlease dated 11 feb 1992
    Brevi particolari
    The deposit of £500,000 held in aseperate designated account at barclays bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Crown Financial Management Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1992Registrazione di un'ipoteca
    Deed of amendment relating to debentures dated 26/09/90 & 18/12/90
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 16 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and/or each obligor (as defined) under the terms of the guarantee (as defined) and this deed of amendment
    Brevi particolari
    (See form 395 and cont'd sheets relevant to this deed of amendment). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as defined) under the terms of the indebtedness agreement the coffee refinancing agreement and this charge.
    Brevi particolari
    (Please see 395 M22 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1991Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 giu 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 set 1990
    Consegnato il 09 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as ined) under the terms of the indebtedness agreements and this charge
    Brevi particolari
    (Please see 395 M21 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1991Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 giu 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 10 lug 1990
    Consegnato il 14 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $3 million dollars due from the company and/or the rayner coffee international partnership to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Assignment of rights arising under a) an agreament dated 17/8/88 b) an agrement supplemental thereof dated 6/9/89 c) a deed of pledge.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 14 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 06 giu 1990
    Consegnato il 27 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A continuing interest in the following property 1) all gold deliverd by cibc to the company on consignment from time to time; and 2) all gold purchased by the company from cibc under the agreement.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transazioni
    • 27 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0