J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED
Panoramica
| Nome della società | J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00704098 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Anns Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 04 set 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maurice Delon Jones il 14 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 14 mar 2010 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Adrian David Gray come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURGESS, Richard Trevor | Segretario | 6 Pleshey Close SS1 3SP Thorpe Bay Essex | British | 36253260001 | ||||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Segretario | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| BURGESS, Richard Trevor | Amministratore | 6 Pleshey Close SS1 3SP Thorpe Bay Essex | British | 36253260001 | ||||||||||
| CUTHBERTSON, George Brian | Amministratore | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | 6996370001 | |||||||||
| DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| GORDON, Alastair Neil | Amministratore | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | 61620710001 | |||||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
| O'CONNOR, Patrick Finbarr | Amministratore delegato nominato | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Amministratore | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
| WILTSHIRE, Harold Phillip | Amministratore | Dipley Mill Dipley RG27 8JP Hartley Wintney Hampshire | British | 930220001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
J.H.RAYNER(MINCING LANE)LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 11 feb 1992 Consegnato il 25 feb 1992 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due under the terms of an underlease dated 11 feb 1992 | |
Brevi particolari The deposit of £500,000 held in aseperate designated account at barclays bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of amendment relating to debentures dated 26/09/90 & 18/12/90 | Creato il 30 set 1991 Consegnato il 16 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parent and/or each obligor (as defined) under the terms of the guarantee (as defined) and this deed of amendment | |
Brevi particolari (See form 395 and cont'd sheets relevant to this deed of amendment). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 set 1990 Consegnato il 09 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as defined) under the terms of the indebtedness agreement the coffee refinancing agreement and this charge. | |
Brevi particolari (Please see 395 M22 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 set 1990 Consegnato il 09 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee (as agent and trustee for itself and for each bank) (as ined) under the terms of the indebtedness agreements and this charge | |
Brevi particolari (Please see 395 M21 and continuation sheets for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 10 lug 1990 Consegnato il 14 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $3 million dollars due from the company and/or the rayner coffee international partnership to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Assignment of rights arising under a) an agreament dated 17/8/88 b) an agrement supplemental thereof dated 6/9/89 c) a deed of pledge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement | Creato il 06 giu 1990 Consegnato il 27 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari A continuing interest in the following property 1) all gold deliverd by cibc to the company on consignment from time to time; and 2) all gold purchased by the company from cibc under the agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0