MANITOWOC POTAIN

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMANITOWOC POTAIN
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00707803
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MANITOWOC POTAIN?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MANITOWOC POTAIN?

    Indirizzo della sede legale
    Manitowoc House, Network 421 Radclive Road
    Gawcott
    MK18 4FD Buckingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MANITOWOC POTAIN?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MANITOWOC POTAIN LIMITED28 mar 200228 mar 2002
    POTAIN U.K. LIMITED27 feb 199227 feb 1992
    CLAESSEN & CO. LIMITED10 nov 196110 nov 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di MANITOWOC POTAIN?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per MANITOWOC POTAIN?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Marie-France Pommaret come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2016

    Stato del capitale al 26 feb 2016

    • Capitale: GBP 115,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 08 giu 2015

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mar 2015

    Stato del capitale al 02 mar 2015

    • Capitale: GBP 115,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mar 2014

    Stato del capitale al 06 mar 2014

    • Capitale: GBP 115,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 24 feb 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    5 pagineMAR

    legacy

    1 pagine49(8)(a)

    Chi sono gli amministratori di MANITOWOC POTAIN?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    BARNETT, Stephen John
    Porchester Mead 53 Southend Road
    BR3 1SP Beckenham
    Kent
    Amministratore
    Porchester Mead 53 Southend Road
    BR3 1SP Beckenham
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director62629660001
    FLOWER, Anthony David
    10 Bolton Close
    DH1 5PH Durham
    Segretario
    10 Bolton Close
    DH1 5PH Durham
    BritishCompany Secretary33413630001
    STEWART, Charles Robert
    Melrose Sunnybank
    Widmer End
    HP15 6PA High Wycombe
    Segretario
    Melrose Sunnybank
    Widmer End
    HP15 6PA High Wycombe
    BritishAccountant64927260004
    MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    Segretario
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    32940220004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    COMBET, Veronique
    46 Rue Du Docteur Ollier
    Villeurbanne 69100
    France
    Amministratore
    46 Rue Du Docteur Ollier
    Villeurbanne 69100
    France
    BritishResponsible For The Finance & Accountancy Departme33545330001
    DESMOLLES, Jean-Marc
    Lane Boissiere
    31 Avenue Paul Santy
    FOREIGN Ecully 69130
    France
    Amministratore
    Lane Boissiere
    31 Avenue Paul Santy
    FOREIGN Ecully 69130
    France
    FrenchExport Director24678050001
    FREAKE, William Eric
    35 Eton Avenue
    Heston
    TW5 0HB Hounslow
    Middlesex
    Amministratore
    35 Eton Avenue
    Heston
    TW5 0HB Hounslow
    Middlesex
    BritishManaging Director24997650001
    GIEBEL JNR, Robert Arthur
    9210 South Cleveland Road
    Cleveland
    Wisconsin
    53015
    Usa
    Amministratore
    9210 South Cleveland Road
    Cleveland
    Wisconsin
    53015
    Usa
    AmericanCompany Director79293920001
    GONZALEZ, Daniel
    Chemin De Champlong
    Le Mirabeau No 9
    69450 Saint Cyr Au Mont Dor
    France
    Amministratore
    Chemin De Champlong
    Le Mirabeau No 9
    69450 Saint Cyr Au Mont Dor
    France
    FrenchSales And Marketing46892760001
    HUBERT, Michel
    25 Rue Jean Boytiste
    Ducrocq
    Marcq En Baroeul
    59700
    France
    Amministratore
    25 Rue Jean Boytiste
    Ducrocq
    Marcq En Baroeul
    59700
    France
    FrenchCommercial Director66852860001
    MULLER, Gerard
    1 Rue Des Chardonnerets
    Chassieu
    69680
    France
    Amministratore
    1 Rue Des Chardonnerets
    Chassieu
    69680
    France
    FrenchDirector70627670001
    POMMARET, Marie-France Sylvia
    73 Rue Duquesne
    69006 Lyon
    France
    Amministratore
    73 Rue Duquesne
    69006 Lyon
    France
    FranceFrenchVp Finance79529810001
    POMMARET, Marie-France Sylvia
    73 Rue Duquesne
    69006 Lyon
    France
    Amministratore
    73 Rue Duquesne
    69006 Lyon
    France
    FranceFrenchFinance Director Regional79529810001
    ROLETTI, Gerard Alain
    18 Rue Chaziere
    Lyon 69004
    France
    Amministratore
    18 Rue Chaziere
    Lyon 69004
    France
    FrenchCommercial Director33545360001
    TAYLOR-THOMAS, Mark Ross
    9 Hayland Close
    Kingsbury
    NW9 0LH London
    Amministratore
    9 Hayland Close
    Kingsbury
    NW9 0LH London
    BritishChartered Accountant17163840001
    THOMPSON, Steven
    25 Springfield Avenue
    Eighton Banks
    NE9 7HL Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    25 Springfield Avenue
    Eighton Banks
    NE9 7HL Gateshead
    Tyne & Wear
    EnglandBritishFinancial Controller90564280001

    MANITOWOC POTAIN ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 11.5.78
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a vernol ganol farm culfor road longhor west glamorgan. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Confirmatory charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 5.7.88
    Brevi particolari
    L/H property k/a 2 queens court 224/234 west end lane. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Confirmatory charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a morgage debenture dated 25.4.83
    Brevi particolari
    The property and assets of the company charged by a mortgage debenture d/d 25/4/83.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Confirmatory charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 14.10.75
    Brevi particolari
    F/H property k/a pen-y-vernell farm culfor road, loughor, west glamorgan. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Confirmatory charge
    Creato il 19 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a legal mortgage dated 14.4.85
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit f horton close west drayton middlesex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1988
    Consegnato il 22 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 2, queens court, 224/234 west end lane, l/b of camden and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 14 gen 1985
    Consegnato il 23 gen 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit f, horton close, west drayton, middlesex t/nos:- ngl 31672 and ngl 41203 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 25 apr 1983
    Consegnato il 04 mag 1983
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 02 mag 1980
    Consegnato il 15 mag 1980
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h and l/h property. All stocks shares or other securities. All book and other debts. Assignment of goodwill. Floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future. (Please see doc M34).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1978
    Consegnato il 23 mag 1978
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as vernol ganol farm culfor road, lougher west glamorgan. As comprised in a conveyance dated 11/5/78.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 1978Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 14 ott 1975
    Consegnato il 15 ott 1975
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Pen-y-vernell farm, culfor road lougher west glamorgan.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1975Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0