IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00708970 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
Dove si trova IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Onslow Street EC1N 8AS London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WESTERN SCREEN & SIGN LTD | 27 set 1995 | 27 set 1995 |
| WESTERN SIGNCRAFT LIMITED | 24 nov 1961 | 24 nov 1961 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 007089700006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 giu 2020 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick James Crean il 06 apr 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Paragon Pallion Trading Estate Sunderland SR4 6st England a 1 Onslow Street London EC1N 8AS in data 25 mar 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020 | 1 pagine | AA01 | ||
Nomina di Mr Richard Joseph Cahill come segretario in data 15 gen 2020 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Laurent Thierry Salmon come amministratore in data 15 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Patrick James Crean come amministratore in data 15 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Terry Robert Smith come amministratore in data 15 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Notifica di Paragon Group Uk Limited come persona con controllo significativo il 15 gen 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Image Factory Communications Ltd come persona con controllo significativo il 15 gen 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Image Centre Bumpers Way Chippenham Wiltshire SN14 6LH a Paragon Pallion Trading Estate Sunderland SR4 6st in data 17 gen 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Terry Robert Smith il 19 apr 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 13 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere 007089700005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL, Richard Joseph | Segretario | EC1N 8AS London 1 Onslow Street England | 266229320001 | |||||||
| CREAN, Patrick James | Amministratore | EC1N 8AS London 1 Onslow Street England | United Kingdom | Irish | 54812330034 | |||||
| SALMON, Laurent Thierry | Amministratore | EC1N 8AS London 1 Onslow Street England | France | French | 152744200001 | |||||
| BHOTE, Cyrus Homi | Segretario | 19 Northwick Avenue HA3 0AA Harrow Middlesex | British | 11159260001 | ||||||
| MOUSLEY, Michael | Segretario | 18 Finchley Way N3 1AG London | British | 10068660001 | ||||||
| BANKS, Geoffrey | Amministratore | Candlemass Cottage Post Office Road Inkpen RG15 0PY Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 22802310002 | |||||
| ELKERTON, Ronald Edward | Amministratore | 1 Bishport Close BS13 9LN Bristol Avon | British | 11996010001 | ||||||
| HULL, Philip Charles | Amministratore | Weir View House Northmoor Road TA22 9DH Dulverton Somerset | United Kingdom | British | 46435360001 | |||||
| KEEGAN, Kevin | Amministratore | 10 Shadwell GL11 5BW Uley Gloucestershire | British | 122669230001 | ||||||
| LEAVER, Marcus Edward | Amministratore | City Road EC1V 2TT London 230 England | United Kingdom | British | 175636880001 | |||||
| MORLEY, Robert | Amministratore | 18 De Beauvoir Square N1 4LD London | United Kingdom | British | 10068650002 | |||||
| MOUSLEY, Michael | Amministratore | 18 Finchley Way N3 1AG London | United Kingdom | British | 10068660001 | |||||
| ORBACH, Laurence | Amministratore | 43 Albert Court SW7 2BL London | United Kingdom | American | 10068640001 | |||||
| SMITH, Terry Robert | Amministratore | Pallion Trading Estate SR4 6ST Sunderland Paragon England | United Kingdom | British | 17155670008 | |||||
| SPARKS, Brian Peter | Amministratore | 2 Ormesby Drive Chandlers Ford SO53 1SH Eastleigh Hampshire | British | 104616810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon Group Uk Limited | 15 gen 2020 | Pallion Trading Estate SR4 6ST Sunderland Paragon England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Image Factory Communications Ltd | 06 apr 2016 | Bumpers Way SN14 6LH Chippenham Image Centre Wiltshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IMAGE FACTORY RETAIL GRAPHICS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 08 mag 2018 Consegnato il 16 mag 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 ott 2013 Consegnato il 22 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 20 mar 2007 Consegnato il 04 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 10 april 2000 and | Creato il 04 mag 2006 Consegnato il 24 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 feb 1993 Consegnato il 01 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee to a limit of £276,000 | |
Brevi particolari F/H property at unit 8 corsham commercial centre corsham wiltshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 26 giu 1987 Consegnato il 01 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on all book and other debts floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0