ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00712831
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Dove si trova ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E & G ESTATES LIMITED22 gen 199022 gen 1990
    ESTATES AND GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    S.E.E.DEVELOPMENTS(BEDFORD)LIMITED12 gen 196212 gen 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2018

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2018

    22 pagineLIQ03

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 set 2017

    2 pagine3.6

    Cessazione della carica di F & C Reit (Corporate Services) Limited come segretario in data 08 ago 2017

    2 pagineTM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2017

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2017

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 set 2016

    1 pagine3.6

    Cessazione della carica di Christopher George White come amministratore in data 11 apr 2016

    2 pagineTM01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2016

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2016

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 set 2015

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2015

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2015

    18 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 set 2014

    3 pagine3.6

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England a C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 26 set 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2014

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2014

    18 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2013

    3 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2013

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 set 2012

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 mar 2012

    3 pagine3.6

    Chi sono gli amministratori di ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Segretario
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish7862560003
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Tenth supplemental trust deed
    Creato il 12 mag 2006
    Consegnato il 15 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Certain houses and shops bearing the numbers 17 and a half, 19 and 21 ''beresford street'' in the parish of st helier vingtaine de haut de la ville in the island of jersey by way of floating charge its undertaking and all its property and assets present and future wheresoever including any uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transazioni
    • 15 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 215 mar 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 210 giu 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 210 giu 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 2
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 25 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brevi particolari
    F/H hayle business park and land adjoining marsh lane hayle cornwall t/n-CL65486 and all property k/a bluebell estate acklam middlesborough cleveland being all that f/h land being 5 to 15A medina gardens 2 to 10A romanby gardens and 13 to 11A lowlane acklam t/n-CE70014 (see form 395 for full details of property charged).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1992
    Consegnato il 24 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates & general PLC and/or the company to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gardens and other properties (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1992
    Consegnato il 17 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and by estates & general PLC to the governor and company of the bank of scotland
    Brevi particolari
    The f/h property k/a plots 87-94 (inclusive) 100 102 104 and 110-113 (inclusive) the croft water lane cornwall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1992
    Consegnato il 17 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and estates & general PLC to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a hayle industrial park and hayle retail park marsh lane hayle cornwall other than plots 3 9 15 and 16 hayle industrial park and an area of 7. 92 square metres.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 04 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties (all as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property at marsh lane,hayle,cornwall and k/a hayle ind' park & retail park see doc M284C for details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1-12A hillel walk,7-21 otterburn gdns',and 2-30A samaria gdns',acklam,middlesborough.t/n CE70053 5-15A medina gdns',2-10A romanby gdns' & 3-11 low lane,acklam,middlesborough.t/n CR70014.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage
    Creato il 29 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee on anyaccount whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a plots 87-94,100,102,104,and 110-113 the croft,water lane,hayle,cornwall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 dic 1991
    Consegnato il 31 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 53-56 bartholomew street, land at 1 st. Nicholas street and st. Michaels road, newbury, berkshire title nos. BK260821 and BK280608.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 mar 1991
    Consegnato il 22 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from estates & general PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    16,18 and 20 bridge street, leatherhead and land adjoining 20 bridge street leatherhead and/or the proceeds of sale thereof t/n sy 336363, sy 485260, sy 357147 and sy 446734. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable charge
    Creato il 26 lug 1990
    Consegnato il 13 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates and general PLC to the chargee
    Brevi particolari
    Prestwood house high wycombe.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 26 lug 1988
    Consegnato il 27 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property k/a ward house, corporation street and castle street, high wycombe.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 gen 1987
    Consegnato il 29 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from estates and general investments public limited company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property k/a 54/56 high street alfreton derbyshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 nov 1986
    Consegnato il 11 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 14,20,22,24 & 26 south street, dorking in the district of mole valley, surrey title no sy 485678 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 ago 1984
    Consegnato il 31 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as blocks a and b, second way avonmouth industrial estate, avonmouth title no av 90348 and av 90349 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 ago 1984
    Consegnato il 31 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H mccelland house, (formerly the power house) headstone lane, harrow. Title no ngl 248936 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 giu 1983
    Consegnato il 28 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a little horwood manor nr bletchley, bucks and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 27 mag 1983
    Consegnato il 06 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second third, and fourth floors 18, 18A and 18B white lion street, norwich, norfolk.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 mag 1983
    Consegnato il 16 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Castle hotel, castle meadow, norwich, norfolk title no:- nk 42785. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 16 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 lug 1981
    Consegnato il 28 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H k/a brook way leatherhead surrey title nos sy 327047 and sy 357185.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ESTATES & GENERAL DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 gen 2011Inizio della liquidazione
    04 gen 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore/gestore
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore/gestore
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ricevitore/gestore
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0