INTERSECTION HOTELS LIMITED

INTERSECTION HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERSECTION HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00712924
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MORGARMAC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED16 gen 196216 gen 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Maple Court Central Park Reeds Crescent Watford Hertfordshire WD24 4QQ

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford Herts WD24 4QQ a 1 More London Place London SE1 2AF in data 17 giu 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 mag 2015

    LRESSP

    Dettagli del direttore cambiati per Oded Lifschitz il 24 giu 2014

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Mark Jonathan Way come amministratore in data 29 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr James Owen Percival come amministratore in data 29 ago 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Stuart Beasley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Rabin come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2014

    Stato del capitale al 05 giu 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Oded Lifschitz come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Rogers come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Philip come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di John Rogers come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INTERSECTION HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish188237620001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Amministratore
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020002
    PERCIVAL, James Owen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish161274380001
    APPEL, Bianca Lesley
    10 Sawtry Way
    WD6 5QJ Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    10 Sawtry Way
    WD6 5QJ Borehamwood
    Hertfordshire
    British55249460001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Segretario
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Segretario
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    ANDREW, David
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Briarclough Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    British41761510002
    BAMSEY, John Anthony
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    Amministratore
    Cranley Road
    Burwood Park
    KT12 5BL Hersham
    Treetops 26
    Surrey
    EnglandBritish130102260001
    BOULD, Christopher John
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The West Wing
    Pensax Court Pensax
    WR6 6XJ Worcester
    Worcestershire
    British110275470001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    DOBBS, John Anthony
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11a North Park Avenue
    LS8 1DN Leeds
    West Yorkshire
    British120544260001
    FARROW, James Roger Charles
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    7 Downham Place
    South Shore
    FY4 1PW Blackpool
    Lancashire
    British9585240001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Amministratore
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Amministratore
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Amministratore
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HIRST, Michael Barry
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    16 Prowse Avenue
    Bushey
    WD2 1JR Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish40994810001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    JONES, Annie Marie
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Lodge Close
    SL7 1RB Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish162019090001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Amministratore
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish143730330001
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British8832120001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Amministratore
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Austria87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102495550001
    POTTER, Anthony Grahame
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Villa Sogno Fulmer Road
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British62316310001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish125139540001
    ROGERS, John
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish162807030001
    SHILL, Rosemarie
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritish89948030001
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish215884620001
    TAYLOR, Hugh Matthew
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    Amministratore
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    United KingdomBritish127621330001
    WAY, Mark Jonathan
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish191239860001

    INTERSECTION HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Further charge
    Creato il 25 gen 1973
    Consegnato il 26 gen 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £34,350
    Brevi particolari
    All property charged in debenture of 18/1/72 to wales tourist board, with all fixtures plant and machinery and all buildings erected there on. (See doc. 23 for more details).
    Persone aventi diritto
    • Wales Tourist Board.
    Transazioni
    • 26 gen 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 12 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 gen 1972
    Consegnato il 19 gen 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £71,196
    Brevi particolari
    All property & uncalled capital & land and buildings at flatwood, chepston rd., Newport.
    Persone aventi diritto
    • Wales Tourist Board.
    Transazioni
    • 19 gen 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 12 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    INTERSECTION HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 lug 2016Data di scioglimento
    21 mag 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0