BRECKLAND PLASTICS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BRECKLAND PLASTICS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00714108 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Mile End Works London Road IP27 0NE Brandon Suffolk England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 10 set 2015 | 22 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Nomina di Ashley Harris come segretario in data 28 set 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr David William Harris come amministratore in data 28 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen William Graham Chase come amministratore in data 28 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jessica Joan Baker come amministratore in data 28 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jessica Joan Baker come segretario in data 28 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Chase Plastics Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Chase Plastics and Recycling Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , the Red House, Methwold, Norfolk, IP26 4PP a Mile End Works London Road Brandon Suffolk IP27 0NE in data 11 set 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, Ashley | Segretario | London Road IP27 0NE Brandon Mile End Works Suffolk England | 250969910001 | |||||||
| HARRIS, David William | Amministratore | London Road IP27 0NE Brandon Mile End Works Suffolk England | Scotland | British | 227366700001 | |||||
| BAKER, Jessica Joan | Segretario | London Road IP27 0NE Brandon Mile End Works Suffolk England | British | 20434230003 | ||||||
| CHASE, Vera Joan Christine | Segretario | Greencroft House 22 Morston Road Blakeney NR25 7BE Holt Norfolk | British | 7141650001 | ||||||
| BAKER, Jessica Joan | Amministratore | London Road IP27 0NE Brandon Mile End Works Suffolk England | United Kingdom | British | 20434230004 | |||||
| CHASE, Bernard Graham Philip | Amministratore | Aketon Lodge Ackton Lane Featherstone WF7 6AT Pontefract West Yorkshire | England | United Kingdom | 7141670001 | |||||
| CHASE, Graham Bernard Stainton | Amministratore | Greencroft House 22 Morston Road Blakeney NR25 7BE Holt Norfolk | British | 7141660001 | ||||||
| CHASE, Stephen William Graham | Amministratore | The Red House 1 Hythe Road Methwold IP26 4PP Thetford Norfolk | United Kingdom | British | 7141680001 | |||||
| CHASE, Vera Joan Christine | Amministratore | Greencroft House 22 Morston Road Blakeney NR25 7BE Holt Norfolk | British | 7141650001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BRECKLAND PLASTICS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Plastics And Recycling Limited | 06 apr 2016 | Hythe Road Methwold IP26 4PP Thetford The Red House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Chase Plastics Limited | 06 apr 2016 | London Road IP27 0NE Brandon Mile End Works England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BRECKLAND PLASTICS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 04 mar 1996 Consegnato il 06 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £275,367.85 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari One erema recycling plant - model RGA120TYE (serial no. C95/068). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second legal charge | Creato il 17 mag 1995 Consegnato il 20 mag 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £45,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land fronting richmond road brandon suffolk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 12 ago 1993 Consegnato il 20 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £19,822.13 | |
Brevi particolari All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 05 ago 1988 Consegnato il 09 ago 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that piece or parcel of land at brandon, county of suffolk having a frontage to london road to northwest of 190 feet or thereabouts together with buildings erected thereon k/a mile end works and the appurtenances belonging together also with the rights of water and drainage. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 mag 1988 Consegnato il 07 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as factory premises at london road, brandon suffolk and assigns the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 19 mag 1988 Consegnato il 27 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land situate at brandon in the county of suffolk having a frontage to london road to the north west of one hundred, and ninety feet or thereabouts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 19 mag 1988 Consegnato il 27 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £800,000.00 | |
Brevi particolari Land situate at brandon in the county of suffolk having a frontage to london road to the north west of one hundred and ninety feet or thereabouts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 dic 1982 Consegnato il 31 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 12 mar 1980 Consegnato il 17 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property greencroft house, marston rd, blaheney, norfolk. Title no nk 2553. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0