SOLARSOFT PMS LIMITED

SOLARSOFT PMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOLARSOFT PMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00718245
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOLARSOFT PMS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Epicor Software Uk Limited No.1 The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STRATEGIC SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED07 set 198707 set 1987
    POWELL DUFFRYN SYSTEMS LIMITED21 mag 198221 mag 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    26 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2014

    Stato del capitale al 11 feb 2014

    • Capitale: GBP 4.1
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2013 al 30 set 2013

    3 pagineAA01

    Nomina di Mr Richard John Clark come amministratore in data 06 giu 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Brims come amministratore in data 06 giu 2013

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Solarsoft House Crockford Lane Basingstoke Hampshire RG24 8WH in data 25 apr 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come segretario in data 28 feb 2013

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Yu-Ho Cheung il 01 nov 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come segretario in data 12 ott 2012

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Shawn Allister Mcmorran come amministratore in data 12 ott 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come amministratore in data 12 ott 2012

    2 pagineTM01

    Nomina di John Brims come amministratore in data 12 ott 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di John Ireland come amministratore in data 12 ott 2012

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come amministratore in data 12 ott 2012

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Kaiser il 26 set 2012

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Shawn Allister Mcmorran il 26 set 2012

    3 pagineCH01

    Memorandum e Statuto

    36 pagineMEM/ARTS

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Chi sono gli amministratori di SOLARSOFT PMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHEUNG, Yu-Ho
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    176259230001
    CHEUNG, Yu-Ho, Mr.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish129862370004
    CLARK, Richard John
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91263440001
    IRELAND, John David
    18101, Suite 1600
    Von Karman Ave
    Irvine
    California 92612
    United States
    Amministratore
    18101, Suite 1600
    Von Karman Ave
    Irvine
    California 92612
    United States
    United StatesAmerican129773050001
    ANDERSON, Martin Spencer
    3 Penshurst Rise
    Frimley
    GU16 8XX Camberley
    Surrey
    Segretario
    3 Penshurst Rise
    Frimley
    GU16 8XX Camberley
    Surrey
    British75932780001
    KAISER, Nicholas
    Huntingdon Unit B
    90278 Redondo Beach
    2111
    California
    Segretario
    Huntingdon Unit B
    90278 Redondo Beach
    2111
    California
    British135071310001
    LEE, Roger Gordon
    Norwyn House
    Broad Meadow Axford
    RG25 2DZ Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Norwyn House
    Broad Meadow Axford
    RG25 2DZ Basingstoke
    Hampshire
    British24025460001
    QUIBELL, John Boyd
    16 Balaclava Road
    KT6 5PN Surbiton
    Surrey
    Segretario
    16 Balaclava Road
    KT6 5PN Surbiton
    Surrey
    British61281750001
    SHUTTLEWORTH, Peter John Whaley
    Mill Lane Cottage
    Bishops Sutton
    SO24 0AA Alresford
    Hampshire
    Segretario
    Mill Lane Cottage
    Bishops Sutton
    SO24 0AA Alresford
    Hampshire
    British13425760001
    STORMONT, Douglas John
    8 Sympson Road
    Tadley
    RG26 3UU Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    8 Sympson Road
    Tadley
    RG26 3UU Basingstoke
    Hampshire
    British13926830001
    ANDERSON, Martin Spencer
    3 Penshurst Rise
    Frimley
    GU16 8XX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    3 Penshurst Rise
    Frimley
    GU16 8XX Camberley
    Surrey
    British75932780001
    BARRINGTON, Dale
    Braybrooke Church Lane
    Boscombe
    RG10 9UA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Braybrooke Church Lane
    Boscombe
    RG10 9UA Reading
    Berkshire
    British57955680001
    BIRCHER, Frederick Max St Lawrence
    3 Grangemuir
    2 Southside Wimbledon Common
    SW19 4TG London
    Amministratore
    3 Grangemuir
    2 Southside Wimbledon Common
    SW19 4TG London
    Canadian Swiss69257150001
    BIRKETT, Joseph William
    56 Eastwood Road
    GU5 0DS Bramley
    Surrey
    Amministratore
    56 Eastwood Road
    GU5 0DS Bramley
    Surrey
    British2077830003
    BOOTON, Glyn Arthur
    10 Prince Rupert Road
    DY13 0AS Stourport
    Worcestershire
    Amministratore
    10 Prince Rupert Road
    DY13 0AS Stourport
    Worcestershire
    British74886290001
    BRIMS, John
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish173964380001
    DANIELS, Richard Charles Harry
    Rose Cottage
    RG26 5RZ Wolverton Common
    Hampshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    RG26 5RZ Wolverton Common
    Hampshire
    British74712640001
    FERRANTI, Adrian Sebastian Ziani De
    Flat 1 43 Rosary Gardens
    SW7 4NQ London
    Amministratore
    Flat 1 43 Rosary Gardens
    SW7 4NQ London
    United KingdomBritish74999250001
    HARRIS, Stephen Clive
    7 Glenmorgan Road
    KT1 4HS Hampton Wick
    Surrey
    Amministratore
    7 Glenmorgan Road
    KT1 4HS Hampton Wick
    Surrey
    British50842160002
    KAISER, Nicholas
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    Amministratore
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    UsaUnited States169823340001
    LAWRENCE, Anthony Moray
    20 Hart Dyke Close
    RG11 3HQ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    20 Hart Dyke Close
    RG11 3HQ Wokingham
    Berkshire
    British30673880002
    LEWIS, Trevor Cameron
    45 Christchurch Road
    SO23 9SY Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    45 Christchurch Road
    SO23 9SY Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish30673890001
    LORD, Stephen Richard
    3 Coombe Manor
    Church Lane
    GU24 9EA Bisley
    Surrey
    Amministratore
    3 Coombe Manor
    Church Lane
    GU24 9EA Bisley
    Surrey
    EnglandBritish55550390003
    LUPTON, Derek
    8 Limekilns Close
    Keynsham
    BS31 1HR Bristol
    Amministratore
    8 Limekilns Close
    Keynsham
    BS31 1HR Bristol
    EnglandBritish83145450001
    MCMORRAN, Shawn Allister
    Lintotts
    Gay Street
    RH20 2HH West Chiltington
    West Sussex
    Amministratore
    Lintotts
    Gay Street
    RH20 2HH West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomCanadian88147450003
    MERRITT, Neville David
    Apple Tree
    Arford Road, Headley
    GU35 8BT Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    Apple Tree
    Arford Road, Headley
    GU35 8BT Bordon
    Hampshire
    EnglandBritish74886270001
    ROSEN, Howard
    Blackberry House Cleves Lane
    Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Blackberry House Cleves Lane
    Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish41986300001
    SHUTTLEWORTH, Peter John Whaley
    Mill Lane Cottage
    Bishops Sutton
    SO24 0AA Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Mill Lane Cottage
    Bishops Sutton
    SO24 0AA Alresford
    Hampshire
    British13425760001

    SOLARSOFT PMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 26 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties; all bank product obligations; and all obligations of each borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tpg Specialty Lending, Inc.
    Transazioni
    • 26 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 22 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Foothill, Inc as Administrative Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 22 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 19 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • D.B. Zwirn Special Opportunities Fund L.P. as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 19 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 lug 2000
    Consegnato il 28 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 16 lug 1999
    Consegnato il 21 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations due from the company to the chargee under a lease dated 16TH july 1999
    Brevi particolari
    The sum of £211,500.
    Persone aventi diritto
    • National Mutual Life Assurance Society
    Transazioni
    • 21 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0