SOLARSOFT PMS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SOLARSOFT PMS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00718245 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SOLARSOFT PMS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Epicor Software Uk Limited No.1 The Arena Downshire Way RG12 1PU Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| STRATEGIC SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 07 set 1987 | 07 set 1987 |
| POWELL DUFFRYN SYSTEMS LIMITED | 21 mag 1982 | 21 mag 1982 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2013 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2013 al 30 set 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard John Clark come amministratore in data 06 giu 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Brims come amministratore in data 06 giu 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Solarsoft House Crockford Lane Basingstoke Hampshire RG24 8WH in data 25 apr 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come segretario in data 28 feb 2013 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Yu-Ho Cheung il 01 nov 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come segretario in data 12 ott 2012 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Shawn Allister Mcmorran come amministratore in data 12 ott 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Kaiser come amministratore in data 12 ott 2012 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di John Brims come amministratore in data 12 ott 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di John Ireland come amministratore in data 12 ott 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Yu-Ho Cheung come amministratore in data 12 ott 2012 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Kaiser il 26 set 2012 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Shawn Allister Mcmorran il 26 set 2012 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 36 pagine | MEM/ARTS | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SOLARSOFT PMS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG, Yu-Ho | Segretario | The Arena Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 1 Berkshire England | 176259230001 | |||||||
| CHEUNG, Yu-Ho, Mr. | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 1 The Arena Berkshire United Kingdom | England | British | 129862370004 | |||||
| CLARK, Richard John | Amministratore | The Arena Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 1 Berkshire England | England | British | 91263440001 | |||||
| IRELAND, John David | Amministratore | 18101, Suite 1600 Von Karman Ave Irvine California 92612 United States | United States | American | 129773050001 | |||||
| ANDERSON, Martin Spencer | Segretario | 3 Penshurst Rise Frimley GU16 8XX Camberley Surrey | British | 75932780001 | ||||||
| KAISER, Nicholas | Segretario | Huntingdon Unit B 90278 Redondo Beach 2111 California | British | 135071310001 | ||||||
| LEE, Roger Gordon | Segretario | Norwyn House Broad Meadow Axford RG25 2DZ Basingstoke Hampshire | British | 24025460001 | ||||||
| QUIBELL, John Boyd | Segretario | 16 Balaclava Road KT6 5PN Surbiton Surrey | British | 61281750001 | ||||||
| SHUTTLEWORTH, Peter John Whaley | Segretario | Mill Lane Cottage Bishops Sutton SO24 0AA Alresford Hampshire | British | 13425760001 | ||||||
| STORMONT, Douglas John | Segretario | 8 Sympson Road Tadley RG26 3UU Basingstoke Hampshire | British | 13926830001 | ||||||
| ANDERSON, Martin Spencer | Amministratore | 3 Penshurst Rise Frimley GU16 8XX Camberley Surrey | British | 75932780001 | ||||||
| BARRINGTON, Dale | Amministratore | Braybrooke Church Lane Boscombe RG10 9UA Reading Berkshire | British | 57955680001 | ||||||
| BIRCHER, Frederick Max St Lawrence | Amministratore | 3 Grangemuir 2 Southside Wimbledon Common SW19 4TG London | Canadian Swiss | 69257150001 | ||||||
| BIRKETT, Joseph William | Amministratore | 56 Eastwood Road GU5 0DS Bramley Surrey | British | 2077830003 | ||||||
| BOOTON, Glyn Arthur | Amministratore | 10 Prince Rupert Road DY13 0AS Stourport Worcestershire | British | 74886290001 | ||||||
| BRIMS, John | Amministratore | Downshire Way RG12 1PU Bracknell No 1 The Arena Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 173964380001 | |||||
| DANIELS, Richard Charles Harry | Amministratore | Rose Cottage RG26 5RZ Wolverton Common Hampshire | British | 74712640001 | ||||||
| FERRANTI, Adrian Sebastian Ziani De | Amministratore | Flat 1 43 Rosary Gardens SW7 4NQ London | United Kingdom | British | 74999250001 | |||||
| HARRIS, Stephen Clive | Amministratore | 7 Glenmorgan Road KT1 4HS Hampton Wick Surrey | British | 50842160002 | ||||||
| KAISER, Nicholas | Amministratore | Reondo Beach California 90278 2111 Huntington Unit B Usa | Usa | United States | 169823340001 | |||||
| LAWRENCE, Anthony Moray | Amministratore | 20 Hart Dyke Close RG11 3HQ Wokingham Berkshire | British | 30673880002 | ||||||
| LEWIS, Trevor Cameron | Amministratore | 45 Christchurch Road SO23 9SY Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 30673890001 | |||||
| LORD, Stephen Richard | Amministratore | 3 Coombe Manor Church Lane GU24 9EA Bisley Surrey | England | British | 55550390003 | |||||
| LUPTON, Derek | Amministratore | 8 Limekilns Close Keynsham BS31 1HR Bristol | England | British | 83145450001 | |||||
| MCMORRAN, Shawn Allister | Amministratore | Lintotts Gay Street RH20 2HH West Chiltington West Sussex | United Kingdom | Canadian | 88147450003 | |||||
| MERRITT, Neville David | Amministratore | Apple Tree Arford Road, Headley GU35 8BT Bordon Hampshire | England | British | 74886270001 | |||||
| ROSEN, Howard | Amministratore | Blackberry House Cleves Lane Upton Grey RG25 2RG Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 41986300001 | |||||
| SHUTTLEWORTH, Peter John Whaley | Amministratore | Mill Lane Cottage Bishops Sutton SO24 0AA Alresford Hampshire | British | 13425760001 |
SOLARSOFT PMS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 26 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties; all bank product obligations; and all obligations of each borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 set 2008 Consegnato il 22 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 11 set 2008 Consegnato il 19 set 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 lug 2000 Consegnato il 28 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 16 lug 1999 Consegnato il 21 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations due from the company to the chargee under a lease dated 16TH july 1999 | |
Brevi particolari The sum of £211,500. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0