RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED

RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00719804
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LRG HOTELS GROUP (UK) LIMITED03 giu 200503 giu 2005
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (UK) LIMITED17 apr 200317 apr 2003
    SIX CONTINENTS HOTELS (UK) LIMITED06 ago 200106 ago 2001
    BASS HOTELS & RESORTS (UK) LIMITED13 gen 200013 gen 2000
    HOLIDAY INNS (UK) LIMITED10 ago 199010 ago 1990
    BASS HOTELS AND HOLIDAYS (UK) LIMITED16 set 198516 set 1985
    PONTIN'S(BOURNEMOUTH)LIMITED29 mar 196229 mar 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 nov 2018

    16 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Justin Bruce Robinson come amministratore in data 14 set 2018

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 22 dic 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 nov 2017

    LRESSP

    Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Michael Teasdale il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Bruce Robinson il 18 dic 2017

    2 pagineCH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 007198040008

    5 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 007198040009

    5 pagineMR05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Patrick Thomas Mabry il 17 nov 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    29 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 ott 2017

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 007198040008

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 007198040008

    5 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Segretario
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish204008350001
    BRIDGE, Michael John Noel
    17 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    Segretario
    17 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    British36370370001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Segretario
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203613710001
    WATERS, Paul Christopher
    23 Derby Road
    Cheam
    SM1 2BL Sutton
    Surrey
    Segretario
    23 Derby Road
    Cheam
    SM1 2BL Sutton
    Surrey
    British32282110001
    WHITNEY, Paul Sumpter
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    Segretario
    The Barnstead
    Evenley
    NN13 5SG Brackley
    Northants
    British418890001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Segretario
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Segretario
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Bishops Square
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Segretario
    Bishops Square
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04131463
    125623230001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    BURKE, Michael Ian
    Rue Mignot Delstranche 70
    FOREIGN 1060 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    Rue Mignot Delstranche 70
    FOREIGN 1060 Brussels
    Belgium
    British50280660001
    BUTCHER, Kenneth Frederick
    Applegarth Moorlane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Applegarth Moorlane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    British1835140001
    CASTON, Robert Warwick
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    Square De Heeus 20
    FOREIGN 1400 Brussels
    Belgium
    British1311840002
    CLARKE, Timothy
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    Amministratore
    63 Wellington Road
    B15 2ET Edgbaston
    Birmingham
    EnglandBritish149229730001
    COWIE, Graham Michael
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage Rays Lane
    Tylers Green
    HP10 8LH Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish63239220001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    GRAHAM, Ian Christopher
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    Amministratore
    Avenue Venus 2
    1410 Waterloo
    Belgium
    British31551670001
    JACKMAN, Robert Loehr
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    4 Durning Place
    SL5 7EZ Ascot
    Berkshire
    American35835670003
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LANGTON, Bryan David
    4185 Fairway Villas Drive
    Alpharetta
    Georgia 30202
    Usa
    Amministratore
    4185 Fairway Villas Drive
    Alpharetta
    Georgia 30202
    Usa
    British57659820001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Amministratore
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Amministratore
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Amministratore
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritish148147140001
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Amministratore
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077
    REES, Sally Irene
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    Amministratore
    3 Sandown Gate
    KT10 9LB Esher
    Surrey
    EnglandBritish49954790002
    RITSON, Leslie David
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    Amministratore
    Old Middle Cator House
    Cator Widecombe In The Moor
    TQ13 7UA Newton Abbot
    Devonshire
    British26098610002
    RITSON, Leslie David
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Nettles
    Cossington Road Sileby
    LE12 7RR Loughborough
    Leicestershire
    British26098610001
    ROBINSON, Justin Bruce
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish225299130001
    ROBINSON, Sarah Margaret Anne
    9 Berkeley Lodge
    Sandal Road
    KT3 5AW New Malden
    Surrey
    Amministratore
    9 Berkeley Lodge
    Sandal Road
    KT3 5AW New Malden
    Surrey
    EnglandBritish67669280002
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Amministratore
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00368815
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 dic 2015
    Consegnato il 02 dic 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transazioni
    • 02 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 01 dic 2015
    Consegnato il 02 dic 2015
    In corso
    Breve descrizione
    L/H property k/a bristol hotel, 5-7 (inc) berkeley street, 49 dover street and 69-72 (inc) piccadilly london t/no NGL854901 and l/h property k/a holiday inn, manor lane, maidenhead and all other plots of land in the instrument. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transazioni
    • 02 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 giu 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 05 set 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 18 dic 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 04 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch, for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transazioni
    • 04 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 04 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch, for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transazioni
    • 04 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 03 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H 129 st nicholas circle leicester t/no LT57900, l/h bristol hotel 5-7 (inc) berkeley street, 49 dover street and 69-72 (inc) piccadilly london t/no NGL854901, l/h land on the north side of cheam road t/no SGL530893 and f/h land at grange employment area woolston warrington t/no CH325746. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transazioni
    • 03 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 set 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 07 apr 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 03 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 28 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 22 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor agreement between the parent, the guarantors, the senior lenders, the junior creditor, the hi creditor (each as defined therein) and the agent (the "intercreditor")
    Creato il 20 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all present and future liabilities payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents
    Brevi particolari
    Non-permitted payment if: (a)a subordinated creditor receives a payment or distribution in cash or kind in respect of or on account of any of the subordinated debt from an obligor or any other source except for a permitted payment - for further details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Agent")
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed legal charge
    Creato il 03 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All secured liabilities of bass PLC pursuant to the trust deed dated 12 february 1993
    Brevi particolari
    F/H property k/a crowne plaza heathrow stockley road west drayton t/n ngl 160680.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Pension Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RIBBON HOTELS GROUP (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 nov 2017Inizio della liquidazione
    03 lug 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0