STAG FURNITURE LIMITED

STAG FURNITURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTAG FURNITURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00722968
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STAG FURNITURE LIMITED?

    • (3611) /
    • (3614) /

    Dove si trova STAG FURNITURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K P M G Corporate Recovery
    Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STAG FURNITURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STAG HOLDINGS LIMITED01 gen 199601 gen 1996
    STAG FURNITURE PLC23 ago 199323 ago 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di STAG FURNITURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 1999

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STAG FURNITURE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STAG FURNITURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 13 gen 2009

    2 pagine2.15

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    16 pagine2.19

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 03 ago 2008

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 03 ago 2008

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Chi sono gli amministratori di STAG FURNITURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOPER, David Christopher
    42 Long Lane
    Honley
    HD9 6EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Segretario
    42 Long Lane
    Honley
    HD9 6EA Holmfirth
    West Yorkshire
    British28917360001
    COOPER, David Christopher
    42 Long Lane
    Honley
    HD9 6EA Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    42 Long Lane
    Honley
    HD9 6EA Holmfirth
    West Yorkshire
    EnglandBritish28917360001
    LLOYD, Mark
    86 Crookesbroom Lane
    Hatfield
    DN7 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    86 Crookesbroom Lane
    Hatfield
    DN7 6LD Doncaster
    South Yorkshire
    British42416170001
    MURRAY, Alan
    38 Park Road
    OL14 5NJ Todmorden
    Lancashire
    Amministratore
    38 Park Road
    OL14 5NJ Todmorden
    Lancashire
    British40341740001
    WOODYER, Keith Rochford
    Home Farm House
    Kington St Michael
    SN14 6HX Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Home Farm House
    Kington St Michael
    SN14 6HX Chippenham
    Wiltshire
    British36947510002
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    RADFORD, Jonathan Vaughan
    Flat 3 Holly Lodge
    Clumber Road West The Park
    NG7 1EF Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Flat 3 Holly Lodge
    Clumber Road West The Park
    NG7 1EF Nottingham
    Nottinghamshire
    British10543730001
    ANDERSON, John Spence
    14 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    14 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Scotland
    British44760800001
    BLANEY, Roger Vaughan
    Morton Hall
    Morton
    NG25 0UY Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Morton Hall
    Morton
    NG25 0UY Southwell
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish37136770001
    BRENTON, John Percy
    10 Bradfield Close
    Woodland Glade Bradley Road
    HD2 1PL Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Bradfield Close
    Woodland Glade Bradley Road
    HD2 1PL Huddersfield
    West Yorkshire
    British45235260002
    BROWN, Stephen John
    Wharferise
    111 Weston Lane
    LS21 2DF Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wharferise
    111 Weston Lane
    LS21 2DF Otley
    West Yorkshire
    British70149030001
    COLVER, Erica Ann
    73 Mount Pleasant Drive
    DE56 2TQ Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    73 Mount Pleasant Drive
    DE56 2TQ Belper
    Derbyshire
    British41870240002
    ELLA, George Henry
    4 Moss Close
    East Bridgford
    NG13 8LG Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Moss Close
    East Bridgford
    NG13 8LG Nottingham
    Nottinghamshire
    British28100100001
    FARR, Ronald
    Greenways 7 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Greenways 7 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BH Leeds
    West Yorkshire
    British38053260001
    FOORD, Derek Fergus Richard
    Low Paddock Barn
    Shelton Newark
    NG25 5JQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Low Paddock Barn
    Shelton Newark
    NG25 5JQ Nottingham
    Nottinghamshire
    British10949320001
    GREENWOOD, Stuart Alan
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    Amministratore
    Winterley House
    Moorber House Coniston Cold
    BD23 4EQ Skipton
    EnglandBritish126211960001
    HEAP, Kenneth Richard
    Cherry Orchard
    Beercrocombe
    TA3 6AJ Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Cherry Orchard
    Beercrocombe
    TA3 6AJ Taunton
    Somerset
    British40833670002
    JACKSON, William Murray
    131 Newdigate Road
    Watnall
    NG16 1HN Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    131 Newdigate Road
    Watnall
    NG16 1HN Nottingham
    Nottinghamshire
    British2422910001
    MATTHEWS, John Antony
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    Amministratore
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    British100850140001
    MURRAY, Alan
    38 Park Road
    OL14 5NJ Todmorden
    Lancashire
    Amministratore
    38 Park Road
    OL14 5NJ Todmorden
    Lancashire
    British40341740001
    PHILLIPS, Fiona Elizabeth
    Tall Trees
    Front Street, Naburn
    YO19 4RR York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tall Trees
    Front Street, Naburn
    YO19 4RR York
    North Yorkshire
    EnglandBritish109520610001
    PROCTOR, John Peter Frederick
    Fylde House Frilsham Park
    Yattendon
    RG16 0XT Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Fylde House Frilsham Park
    Yattendon
    RG16 0XT Newbury
    Berkshire
    British43761010001
    RADFORD, Jonathan Vaughan
    Flat 3 Holly Lodge
    Clumber Road West The Park
    NG7 1EF Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Flat 3 Holly Lodge
    Clumber Road West The Park
    NG7 1EF Nottingham
    Nottinghamshire
    British10543730001
    ROONEY, William Thomas
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Treetops Northedge Lane
    Norwood Green
    HX8 3AG Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish18244740001
    ROSSI, Valentino Giulio
    27a Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    27a Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Scotland
    British36947440001
    TOWERS, Martin George
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Linton House Avenue Des Hirondelles
    Pool In Wharfedale
    LS21 1EY Otley
    West Yorkshire
    British36252860002
    WEAVER, Paul
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 High Street
    Farsley
    LS28 5LH Pudsey
    West Yorkshire
    British45193280001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002

    STAG FURNITURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 11 mag 1999
    Consegnato il 27 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All obligations and liabilities owing by the company and nottcor 85 limited to the chargee under any finance document (as defined) or any other doucment
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bny International Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 11 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 17 set 1993
    Consegnato il 22 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STAG FURNITURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 ago 2000Inizio dell'amministrazione
    13 gen 2009Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Praticante
    Kpmg
    St Nicholas House
    NG1 6FQ Park Row
    Nottingham
    Myles Anthony Halley
    Kpmg
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    Kpmg
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0