HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED

HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00726089
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAYS BUSINESS SERVICES LTD15 nov 198815 nov 1988
    HAYS BUSINESS SERVICES LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    HAY'S WHARF HAULAGE(S.W.)LIMITED04 giu 196204 giu 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2022

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2021

    12 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Morte di un liquidatore

    3 pagineLIQ09

    Cessazione della carica di Ian David Pratt come amministratore in data 19 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2020

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2019

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 250 Euston Road London NW1 2AF a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 25 giu 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2018

    LRESSP

    Cessazione della carica di Paul Venables come amministratore in data 14 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas George Evans come amministratore in data 14 mag 2018

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 gen 2018

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 21/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    5 pagineRP04CS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYS NOMINEES LIMITED
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Segretario
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione928949
    100317500002
    BAXTER, David Malcolm
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    British18407470001
    BORT, Stefan Edward
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Segretario
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    British32824200011
    LAYTON, Robert
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    10 Cherry Hill
    Old
    NN6 9EN Northampton
    Northamptonshire
    British75448020002
    PRENTICE, Anthony Frank
    Abbey Wells Cottage
    Woolton Hill
    RG15 9UW Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Abbey Wells Cottage
    Woolton Hill
    RG15 9UW Newbury
    Berkshire
    British29038600001
    REAY, Sally Jane
    34 Sedgmoor Road
    Flackwell Heath
    HP10 9AP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    34 Sedgmoor Road
    Flackwell Heath
    HP10 9AP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British41603850002
    STOCK, John Patrick
    Belton 3a Highlands Road
    Heath End
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    Segretario
    Belton 3a Highlands Road
    Heath End
    GU9 0LX Farnham
    Surrey
    British30640450001
    ALDRIDGE, Mark Ewart
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Rustlings Park
    Woodlands Lane
    GU33 7EZ Liss
    Hampshire
    EnglandBritish66832950001
    BAXTER, David Malcolm
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    42 Symons Avenue
    Eastwood
    SS9 5QE Leigh On Sea
    Essex
    British18407470001
    BERRY, Mark Ian James
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Amministratore
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish96582270003
    BIDEN, Michael James
    St Giles Hilltop Northbrook Close
    SO23 0JR Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    St Giles Hilltop Northbrook Close
    SO23 0JR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish55905440001
    BROUGHAM, Peter David
    25 Limes Way
    Shabbington
    HP18 9HB Aylesbury
    Amministratore
    25 Limes Way
    Shabbington
    HP18 9HB Aylesbury
    EnglandBritish114600540001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bridge Cottage
    6 Hodges Lane
    NN7 4AJ Kislingbury
    Northamptonshire
    British95347040001
    CHARLTON, Keith Pearson
    The Coach House
    Duncote
    NN12 8AQ Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Coach House
    Duncote
    NN12 8AQ Towcester
    Northamptonshire
    British51102460005
    COLE, John Robert
    Dairy Farm Sutton Hoo
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Dairy Farm Sutton Hoo
    IP12 3DJ Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish49591410003
    DOBSON, Peter, Dr
    23 Beeches End
    Boston Spa
    LS23 6HL Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Beeches End
    Boston Spa
    LS23 6HL Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish35270770001
    EVANS, Douglas George
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    Amministratore
    250 Euston Road
    London
    NW1 2AF
    EnglandBritish78234950002
    FROST, Ronald Edwin
    Thorncombe Park Thorncombe Street
    Bramley
    GU5 0ND Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Thorncombe Park Thorncombe Street
    Bramley
    GU5 0ND Guildford
    Surrey
    British6339840002
    FULLER, Brian Leslie
    Cotswold House
    Hoo Lane
    GL55 6AZ Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cotswold House
    Hoo Lane
    GL55 6AZ Chipping Campden
    Gloucestershire
    British36745670001
    GLEESON, Paul
    Foxhaunt House
    100 Saint Andrews Road
    RG9 1PL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Foxhaunt House
    100 Saint Andrews Road
    RG9 1PL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British69637020001
    GRAY, Simon
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    Amministratore
    250 Euston Road
    NW1 2AF London
    British106274260003
    HARRISON, Michael John
    16 Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    16 Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    Northamptonshire
    British80215760001
    HEWITT, Trevor
    3 Stafford Close
    Lang Farm
    NN11 5GN Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    3 Stafford Close
    Lang Farm
    NN11 5GN Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritish75727820001
    HODGSON, John Gordon
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    Amministratore
    1 Stone Cottages
    The Street, Starston
    IP20 9NP Harleston
    Norfolk
    British65293600001
    LAWSON, Robert Arthur
    141 Moorgate
    EC2M 6TX London
    Amministratore
    141 Moorgate
    EC2M 6TX London
    British9230610003
    LEWIS, Colin Ernest
    Willow Creek
    Mill Creek Court, Chertsey Road
    TW17 9LA Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    Willow Creek
    Mill Creek Court, Chertsey Road
    TW17 9LA Shepperton
    Middlesex
    United KingdomBritish69553890001
    MARTIN, John Walley
    Locksley
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Locksley
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    British143523590001
    MATTHEWS, Colin Stephen
    Millmead
    GU2 4HJ Guildford
    Hays House
    Surrey
    Amministratore
    Millmead
    GU2 4HJ Guildford
    Hays House
    Surrey
    United KingdomBritish55866900003
    MCLACHLAN, Neil Andrew
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Deise
    Langhurstwood Road
    RH12 4QD Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish78366690001
    MORGAN, Robert James
    23 St Georges Road
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    23 St Georges Road
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    British60273420001
    MOUNSEY, Simon Charles Finch
    Barnes House
    Piltdown
    TN22 3XN Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Barnes House
    Piltdown
    TN22 3XN Uckfield
    East Sussex
    British18969920001
    NAPIER, John Alan
    Slough Farm House Slough Lane
    Headley
    KT18 6NZ Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Slough Farm House Slough Lane
    Headley
    KT18 6NZ Epsom
    Surrey
    British9716880003
    PRATT, Ian David
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    Amministratore
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    EnglandBritish216303100001
    PRENTICE, Anthony Frank
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Thatched Cottage
    Ball Hill
    RG20 0PD Newbury
    Berkshire
    British65443130002
    RICHARDSON, David Gordon
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    Amministratore
    Water Lane
    Radwinter
    CB10 2TX Saffron Walden
    Haselbury House
    Essex
    British50331150002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Euston Road
    NW1 2AF London
    250
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione93338
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 and
    Creato il 14 gen 2008
    Consegnato il 31 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement)
    Creato il 18 feb 2005
    Consegnato il 10 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement)
    Creato il 17 ott 2003
    Consegnato il 22 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,000,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Borthwick wharf and land on the north east side of borthwick street and paynes wharf deptford london SE8 t/n TGL178058 and TGL178052.
    Persone aventi diritto
    • George Wimpey Central London Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 1989
    Consegnato il 14 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 19TH nov, 1987.
    Brevi particolari
    Land in levon road, title no 88586. land fronting bow greek river lee title no. 106593 land on the east side of leven road title no. 147899 all in the L.B. of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transazioni
    • 14 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 lug 1989
    Consegnato il 07 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee for the banks under or by virtue of a guarantee and debenture dated 19/11/87
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on north side of derby street, manchester title no la 332096 f/h land k/a paynes wharf, deptford greenwich title no sgl 337627.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Webb Limited
    Transazioni
    • 07 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee and composite trust debenture
    Creato il 19 nov 1987
    Consegnato il 24 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclays de zoete wedd limited as trustee under the terms of this guarantee and debenture and/or the overdraft letters of even date.
    Brevi particolari
    (See doc M244/NOV25/ct for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays De Zoete Wedd Limitedas Trustee.
    Transazioni
    • 24 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set off
    Creato il 10 giu 1983
    Consegnato il 29 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any account of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 1983Registrazione di un'ipoteca

    HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2018Inizio della liquidazione
    14 gen 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Matthew James Chadwick
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Praticante
    2nd Floor 2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0