HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00726089 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HAYS BUSINESS SERVICES LTD | 15 nov 1988 | 15 nov 1988 |
| HAYS BUSINESS SERVICES LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| HAY'S WHARF HAULAGE(S.W.)LIMITED | 04 giu 1962 | 04 giu 1962 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 19 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2022 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2021 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Morte di un liquidatore | 3 pagine | LIQ09 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ian David Pratt come amministratore in data 19 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2020 | 13 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 mag 2019 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 250 Euston Road London NW1 2AF a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 25 giu 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Venables come amministratore in data 14 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Douglas George Evans come amministratore in data 14 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 09 gen 2018
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 5 pagine | RP04CS01 | ||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYS NOMINEES LIMITED | Segretario | 250 Euston Road NW1 2AF London |
| 100317500002 | ||||||||||
| BAXTER, David Malcolm | Segretario | 42 Symons Avenue Eastwood SS9 5QE Leigh On Sea Essex | British | 18407470001 | ||||||||||
| BORT, Stefan Edward | Segretario | 250 Euston Road NW1 2AF London | British | 32824200011 | ||||||||||
| LAYTON, Robert | Segretario | 10 Cherry Hill Old NN6 9EN Northampton Northamptonshire | British | 75448020002 | ||||||||||
| PRENTICE, Anthony Frank | Segretario | Abbey Wells Cottage Woolton Hill RG15 9UW Newbury Berkshire | British | 29038600001 | ||||||||||
| REAY, Sally Jane | Segretario | 34 Sedgmoor Road Flackwell Heath HP10 9AP High Wycombe Buckinghamshire | British | 41603850002 | ||||||||||
| STOCK, John Patrick | Segretario | Belton 3a Highlands Road Heath End GU9 0LX Farnham Surrey | British | 30640450001 | ||||||||||
| ALDRIDGE, Mark Ewart | Amministratore | Rustlings Park Woodlands Lane GU33 7EZ Liss Hampshire | England | British | 66832950001 | |||||||||
| BAXTER, David Malcolm | Amministratore | 42 Symons Avenue Eastwood SS9 5QE Leigh On Sea Essex | British | 18407470001 | ||||||||||
| BERRY, Mark Ian James | Amministratore | 250 Euston Road London NW1 2AF | England | British | 96582270003 | |||||||||
| BIDEN, Michael James | Amministratore | St Giles Hilltop Northbrook Close SO23 0JR Winchester Hampshire | England | British | 55905440001 | |||||||||
| BROUGHAM, Peter David | Amministratore | 25 Limes Way Shabbington HP18 9HB Aylesbury | England | British | 114600540001 | |||||||||
| CASSELLS, Leslie James Davidson | Amministratore | Bridge Cottage 6 Hodges Lane NN7 4AJ Kislingbury Northamptonshire | British | 95347040001 | ||||||||||
| CHARLTON, Keith Pearson | Amministratore | The Coach House Duncote NN12 8AQ Towcester Northamptonshire | British | 51102460005 | ||||||||||
| COLE, John Robert | Amministratore | Dairy Farm Sutton Hoo IP12 3DJ Woodbridge Suffolk | England | British | 49591410003 | |||||||||
| DOBSON, Peter, Dr | Amministratore | 23 Beeches End Boston Spa LS23 6HL Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 35270770001 | |||||||||
| EVANS, Douglas George | Amministratore | 250 Euston Road London NW1 2AF | England | British | 78234950002 | |||||||||
| FROST, Ronald Edwin | Amministratore | Thorncombe Park Thorncombe Street Bramley GU5 0ND Guildford Surrey | British | 6339840002 | ||||||||||
| FULLER, Brian Leslie | Amministratore | Cotswold House Hoo Lane GL55 6AZ Chipping Campden Gloucestershire | British | 36745670001 | ||||||||||
| GLEESON, Paul | Amministratore | Foxhaunt House 100 Saint Andrews Road RG9 1PL Henley On Thames Oxfordshire | British | 69637020001 | ||||||||||
| GRAY, Simon | Amministratore | 250 Euston Road NW1 2AF London | British | 106274260003 | ||||||||||
| HARRISON, Michael John | Amministratore | 16 Senna Drive NN12 7AU Towcester Northamptonshire | British | 80215760001 | ||||||||||
| HEWITT, Trevor | Amministratore | 3 Stafford Close Lang Farm NN11 5GN Daventry Northamptonshire | United Kingdom | British | 75727820001 | |||||||||
| HODGSON, John Gordon | Amministratore | 1 Stone Cottages The Street, Starston IP20 9NP Harleston Norfolk | British | 65293600001 | ||||||||||
| LAWSON, Robert Arthur | Amministratore | 141 Moorgate EC2M 6TX London | British | 9230610003 | ||||||||||
| LEWIS, Colin Ernest | Amministratore | Willow Creek Mill Creek Court, Chertsey Road TW17 9LA Shepperton Middlesex | United Kingdom | British | 69553890001 | |||||||||
| MARTIN, John Walley | Amministratore | Locksley Tennysons Lane GU27 3AF Haslemere Surrey | British | 143523590001 | ||||||||||
| MATTHEWS, Colin Stephen | Amministratore | Millmead GU2 4HJ Guildford Hays House Surrey | United Kingdom | British | 55866900003 | |||||||||
| MCLACHLAN, Neil Andrew | Amministratore | Deise Langhurstwood Road RH12 4QD Horsham West Sussex | England | British | 78366690001 | |||||||||
| MORGAN, Robert James | Amministratore | 23 St Georges Road TW1 1QS Twickenham Middlesex | British | 60273420001 | ||||||||||
| MOUNSEY, Simon Charles Finch | Amministratore | Barnes House Piltdown TN22 3XN Uckfield East Sussex | British | 18969920001 | ||||||||||
| NAPIER, John Alan | Amministratore | Slough Farm House Slough Lane Headley KT18 6NZ Epsom Surrey | British | 9716880003 | ||||||||||
| PRATT, Ian David | Amministratore | Euston Road NW1 2AF London 250 United Kingdom | England | British | 216303100001 | |||||||||
| PRENTICE, Anthony Frank | Amministratore | The Thatched Cottage Ball Hill RG20 0PD Newbury Berkshire | British | 65443130002 | ||||||||||
| RICHARDSON, David Gordon | Amministratore | Water Lane Radwinter CB10 2TX Saffron Walden Haselbury House Essex | British | 50331150002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hays Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Euston Road NW1 2AF London 250 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 and | Creato il 14 gen 2008 Consegnato il 31 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement) | Creato il 18 feb 2005 Consegnato il 10 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 17TH august 1999 (the agreement) | Creato il 17 ott 2003 Consegnato il 22 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 lug 2002 Consegnato il 05 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,000,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Borthwick wharf and land on the north east side of borthwick street and paynes wharf deptford london SE8 t/n TGL178058 and TGL178052. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 ago 1989 Consegnato il 14 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee and debenture dated 19TH nov, 1987. | |
Brevi particolari Land in levon road, title no 88586. land fronting bow greek river lee title no. 106593 land on the east side of leven road title no. 147899 all in the L.B. of tower hamlets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 31 lug 1989 Consegnato il 07 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee for the banks under or by virtue of a guarantee and debenture dated 19/11/87 | |
Brevi particolari F/H land & buildings on north side of derby street, manchester title no la 332096 f/h land k/a paynes wharf, deptford greenwich title no sgl 337627. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and composite trust debenture | Creato il 19 nov 1987 Consegnato il 24 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclays de zoete wedd limited as trustee under the terms of this guarantee and debenture and/or the overdraft letters of even date. | |
Brevi particolari (See doc M244/NOV25/ct for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of set off | Creato il 10 giu 1983 Consegnato il 29 giu 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari Any account of the company with lloyds bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
HAYS COMMERCIAL SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0