SBJ UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSBJ UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00726955
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SBJ UK LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SBJ UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SBJ UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SBJ STEPHENSON LIMITED05 set 199005 set 1990
    STEPHENSON CORPORATE RISKS LIMITED10 mar 198910 mar 1989
    H. STEPHENSON & COMPANY LIMITED 31 dic 198031 dic 1980
    H. STEPHENSON & CO. (NORTHERN) LIMITED15 giu 196215 giu 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di SBJ UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SBJ UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 20 dic 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Ian Story come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Martin Keith Tyler come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Reid come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Parsons come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jane Bean come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Coates come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Charles Reid il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Jane Ann Bean il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Darryl Druckman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart Richard Clarke il 30 apr 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Kenneth Parsons il 23 apr 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SBJ UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British135642970001
    CLARKE, Stuart Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish151061560001
    TYLER, Martin Keith
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Great BritainBritish158372390001
    BIRRELL, Christopher Ros Stewart
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    Segretario
    Turret Grove
    Clapham
    SW4 0ES London
    25
    United Kingdom1464480001
    COLE, Simon Lawrence Vernon
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Segretario
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    British50520880006
    ACTON, Andrew John
    12 Marsland Road
    Marple
    SK6 6HD Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    12 Marsland Road
    Marple
    SK6 6HD Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish67844620002
    ASHWORTH, Diane Pamela
    22 Mincing Lane
    Chobham
    GU24 8RX Woking
    Surrey
    Amministratore
    22 Mincing Lane
    Chobham
    GU24 8RX Woking
    Surrey
    British79819410001
    BAKER, Judith
    The Farm House
    Manor Farm Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Farm House
    Manor Farm Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    British74405300002
    BALL, Robert Neill
    365 Newton Road
    Lowton
    WA3 1NU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    365 Newton Road
    Lowton
    WA3 1NU Warrington
    Cheshire
    British28786200001
    BARRATT, William Melsom
    25 Tadorne Road
    KT20 5TD Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    25 Tadorne Road
    KT20 5TD Tadworth
    Surrey
    British2358910001
    BATH, John Montague
    16 Ruskin Drive
    KT4 8LG Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    16 Ruskin Drive
    KT4 8LG Worcester Park
    Surrey
    British28786210001
    BEAN, Jane Ann
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish158293780001
    BENNETT, John Duncan Irvine
    Coram Street Farm
    IP7 5NE Hadleigh
    Suffolk
    Amministratore
    Coram Street Farm
    IP7 5NE Hadleigh
    Suffolk
    United KingdomBritish82156080001
    BODEN, George
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    One Hundred Whitechapel
    Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritish149286650001
    BROWNRIGG, Gordon Mark
    21 Hawkswood Avenue
    Frimley
    GU16 8LH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    21 Hawkswood Avenue
    Frimley
    GU16 8LH Camberley
    Surrey
    British127099460001
    BRUCE, John Clifford
    8 The Pines
    RH4 2BE Dorking
    Surrey
    Amministratore
    8 The Pines
    RH4 2BE Dorking
    Surrey
    British8955920001
    CAMERON-ROSE, Hugh Alastair
    25c Kelso Place
    W8 5QG London
    Amministratore
    25c Kelso Place
    W8 5QG London
    British28786240001
    CLEWS, Jeremy Mark
    8 Parkside Crescent
    KT5 9HT Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    8 Parkside Crescent
    KT5 9HT Surbiton
    Surrey
    British37438170003
    COATES, Graham Marshall
    Grange Road
    W5 3PH London
    107
    United Kingdom
    Amministratore
    Grange Road
    W5 3PH London
    107
    United Kingdom
    EnglandBritish139593550002
    CRESSWELL, Steven John
    Whyteleaf
    Brentmoor Road, West End
    GU24 9NN Woking
    Surrey
    Amministratore
    Whyteleaf
    Brentmoor Road, West End
    GU24 9NN Woking
    Surrey
    EnglandBritish79830850001
    DAVIES, John Barry
    183 Sutton Road
    SY2 6QT Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    183 Sutton Road
    SY2 6QT Shrewsbury
    Salop
    British3802540001
    DOIDGE, Ronald
    Treforris 45 South Parade
    SK7 3BJ Bramhall
    Cheshire
    Amministratore
    Treforris 45 South Parade
    SK7 3BJ Bramhall
    Cheshire
    British52375300001
    DRUCKMAN, Darryl Martin
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish18047610001
    DUNN, Stuart Richard
    301 Wells Road
    Knowle
    BS4 2PT Bristol
    Avon
    Amministratore
    301 Wells Road
    Knowle
    BS4 2PT Bristol
    Avon
    United KingdomBritish87708650001
    DYER, Richard John
    Godwell Farm
    Church Road Offham
    ME19 5NX West Malling
    Kent
    Amministratore
    Godwell Farm
    Church Road Offham
    ME19 5NX West Malling
    Kent
    British28786260002
    EVANS, Ian David
    19h Paveley Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    Amministratore
    19h Paveley Drive
    Morgans Walk
    SW11 3TP London
    British38736070004
    FORSYTH, Neil Richard
    34 Thornbera Gardens
    CM23 3NP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Thornbera Gardens
    CM23 3NP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British87208000002
    FRYER, Howard Ian
    6 Falconwood
    KT24 5EG East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    6 Falconwood
    KT24 5EG East Horsley
    Surrey
    British49302570002
    FRYER, Howard Ian
    37 Sole Farm Road
    Bookham
    KT23 3DW Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    37 Sole Farm Road
    Bookham
    KT23 3DW Leatherhead
    Surrey
    British49302570001
    GARSIDE, William John
    17 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Cannon Hall Drive
    Clifton
    HD6 4JR Brighouse
    West Yorkshire
    British13981480002
    GREEN, Christopher Bernard
    19 Mendip Lea Close
    BS27 3SY Draycott
    Somerset
    Amministratore
    19 Mendip Lea Close
    BS27 3SY Draycott
    Somerset
    British18665340001
    GRIFFITHS, Celia Margaret
    23 Woodlands Avenue
    GU9 9EY Farnham
    Surrey
    Amministratore
    23 Woodlands Avenue
    GU9 9EY Farnham
    Surrey
    British43970150001
    HANDS, James Michael
    1 Mayston Mews
    SE10 0LY London
    Amministratore
    1 Mayston Mews
    SE10 0LY London
    United KingdomBritish83729920001
    HARTLEY, Stuart Neil
    The Paddocks 10 West View
    BD16 3ED Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Paddocks 10 West View
    BD16 3ED Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish59712860001
    HEAGIN, Joan Christine
    One Lane House
    22 Busbridge Lane
    GU7 1PU Godalming
    Surrey
    Amministratore
    One Lane House
    22 Busbridge Lane
    GU7 1PU Godalming
    Surrey
    EnglandBritish28786290002

    SBJ UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed in respect of a mortgage debenture and a composite guarantee both dated 9 june 1999 issued by the company
    Creato il 31 dic 2001
    Consegnato il 10 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 19 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0