XD COMMUNICATIONS LIMITED

XD COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàXD COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00730286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Smiths Group Plc
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DOWTY COMMUNICATIONS LIMITED04 mar 199104 mar 1991
    CASE COMMUNICATIONS LIMITED18 apr 198518 apr 1985
    SUMMIT PATTERNMAKING CO. LIMITED19 lug 196219 lug 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 mag 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Marc Furlonger come amministratore in data 19 apr 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Robin Mckeown come amministratore in data 19 apr 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2017

    2 pagineAA

    Nomina di Matthew Robin Mckeown come amministratore in data 21 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alexandra Ralph come amministratore in data 21 nov 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 31 lug 2017

    1 pagineAA01

    Nomina di Miss Fiona Margaret Gillespie come amministratore in data 05 apr 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Robert Burdett come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Alexandra Ralph come amministratore in data 05 apr 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Robert Burdett il 25 lug 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Fiona Margaret Gillespie il 25 lug 2016

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smiths Group Plc 2nd Floor Cardinal Place 80 Victoria Street London SW1E 5JL a C/O Smiths Group Plc 4th Floor, 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB in data 25 lug 2016

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILLESPIE, Fiona Margaret
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    4th Floor
    England
    Segretario
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    4th Floor
    England
    Other97576610003
    FURLONGER, Marc
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    Amministratore
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    EnglandBritish98322410002
    GILLESPIE, Fiona Margaret
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    Amministratore
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    EnglandBritish229862900001
    BUCHAN, Jennifer Susan
    Highdown
    Greenway Road
    GL56 9BQ Blockley
    Gloucestershire
    Segretario
    Highdown
    Greenway Road
    GL56 9BQ Blockley
    Gloucestershire
    British32414310001
    MUNFORD, Marina Elizabeth Florence
    6 Birch Copse
    Bricket Wood
    AL2 3UT St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Birch Copse
    Bricket Wood
    AL2 3UT St Albans
    Hertfordshire
    British10478120001
    PENN, David Alfred
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    Segretario
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    British64115230001
    BAYLY, Anthony Edward
    65 Sandelswood End
    HP9 2AA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    65 Sandelswood End
    HP9 2AA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British57140190001
    BRAIN, Bruce
    West Sevington Farmhouse
    Yatton Keynell
    SN15 4NB Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    West Sevington Farmhouse
    Yatton Keynell
    SN15 4NB Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish9395440004
    BURDETT, Neil Robert
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    4th Floor
    England
    Amministratore
    11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    4th Floor
    England
    EnglandBritish188620005
    DONOVAN, Terence John
    20 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    20 Devereux Road
    SL4 1JJ Windsor
    Berkshire
    UkBritish88334080001
    EDWARDS, John Ralph
    Green Hedges
    25 Saint Johns Street
    RG45 7NJ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    Green Hedges
    25 Saint Johns Street
    RG45 7NJ Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritish60448890001
    HARDING, David Alan
    Cedar House
    22 Plymouth Road
    B45 8JA Barnt Green
    Birmingham
    Amministratore
    Cedar House
    22 Plymouth Road
    B45 8JA Barnt Green
    Birmingham
    EnglandBritish80124630001
    LILLYCROP, David Peter
    Canal Cottage
    HP22 5NS Halton Village
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Canal Cottage
    HP22 5NS Halton Village
    Buckinghamshire
    American32621210001
    MCKEOWN, Matthew Robin
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    Amministratore
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    EnglandBritish240492390001
    MOORE, Nicholas
    The Balfour Chatterpie Lane
    Combe
    OX29 8PG Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Balfour Chatterpie Lane
    Combe
    OX29 8PG Witney
    Oxfordshire
    United KingdomBritish30223240001
    NORRIS, Guy Mervyn
    The Dower House
    Church Road Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Amministratore
    The Dower House
    Church Road Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    British813530001
    O'BRIEN, Susan Lynn
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    180 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    British123851410001
    PENN, David Alfred
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    Amministratore
    2 Salmons Lane
    Middleton Cheney
    OX17 2NF Banbury
    Oxon
    EnglandBritish64115230001
    RALPH, Alexandra
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    Amministratore
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    EnglandBritish183196610001
    RICHARDSON, Malcolm David, Me
    34 Parkfield Rickmansworth Road
    Chorleywood
    WD3 5AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Parkfield Rickmansworth Road
    Chorleywood
    WD3 5AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    British37287720001
    SAUNDERS, Denis
    Lime Tree House 3 Tapster Court
    Bushwood Lane
    B94 5PJ Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Lime Tree House 3 Tapster Court
    Bushwood Lane
    B94 5PJ Lapworth
    Warwickshire
    British7290090001
    SMERDON, Gary Lloyd
    23 The Grove
    Latimer
    HP5 1UE Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    23 The Grove
    Latimer
    HP5 1UE Chesham
    Buckinghamshire
    Australian10468550001
    WALKER, Denis
    28 Lionel Street
    BB12 6DY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    28 Lionel Street
    BB12 6DY Burnley
    Lancashire
    British6240800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di XD COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    06 apr 2016
    4th Floor, 11-12 St James's Square
    SW1Y 4LB London
    C/O Smiths Group Plc
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00530526
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    XD COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 24 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the"moneys and liabilities" (as defined) under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    (Details as above but please ref to doc M395 and attached scheduel thereto for full details by M107/oct 2/cf).
    Persone aventi diritto
    • Midland Montagu Leasing Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 24 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the"moneys and liabilities" (as defined) under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Floating charge over all the but excludint all book and other debts (as defined) (please refer to M395 and attached schedule thereto for full details ry - M106/oct 28/d). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Montagu Leasing (Bsh) Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 22 mag 1987
    Consegnato il 09 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a counter indemnity agreemtn dated 31.03.87 and/or this charge
    Brevi particolari
    All the business undertaking goodwill & other property both present & future including its unsecured capital for the time being of case communications limited.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage & deed of postponent
    Creato il 22 mag 1987
    Consegnato il 09 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a counter indemnity agreement dated 31.03.87 and/or this charge
    Brevi particolari
    All that l/h land & buildings situate and lying on the east side of caxton way watford business park watford tns hd 184074 and hd 184073.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (UK) Limited
    Transazioni
    • 09 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 15 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from theco. To national westminster bank PLC as trustee for itself and international westminster bank PLC as those moneys are described in paragraphs 1 to 4 of clause 2OF the mortgage debenture.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery & (trade machinery) goodwill, licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rightsin the nature of copyright and all otherintellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • International Westminster Bank PLC.
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 15 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due ot to become due from the company to samuel montagu & co limited as trustee for itself and midland bank PLC as those moneys are described in paragraphis (1) to (4) of clause 2 of the mortgage debenture.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery ( & trade machinery) goodwill licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rights in the nature of copyright and all otherintellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited and Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 01 set 1986
    Consegnato il 15 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the senwa bank limited as those moneys are described in paragraphs (1) to (4) of clause 2 of the mortgage debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (including trade machinery) goodwill, licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rightsin the nature of copyright and all otherintellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • The Sanwa Bank LTD
    Transazioni
    • 15 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    First legal charge.
    Creato il 17 mag 1985
    Consegnato il 23 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of a facility letter dated 7/8/84 (as amended by a letter dated 3/5/85.
    Brevi particolari
    L/H land situate at caxton way and forming part of the watford business park extension, borough of watford, hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. LTD.
    Transazioni
    • 23 mag 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0