XD COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | XD COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00730286 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di XD COMMUNICATIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Smiths Group Plc 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DOWTY COMMUNICATIONS LIMITED | 04 mar 1991 | 04 mar 1991 |
| CASE COMMUNICATIONS LIMITED | 18 apr 1985 | 18 apr 1985 |
| SUMMIT PATTERNMAKING CO. LIMITED | 19 lug 1962 | 19 lug 1962 |
Quali sono gli ultimi bilanci di XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 lug 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 14 mag 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Marc Furlonger come amministratore in data 19 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Robin Mckeown come amministratore in data 19 apr 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Matthew Robin Mckeown come amministratore in data 21 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexandra Ralph come amministratore in data 21 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 31 lug 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Miss Fiona Margaret Gillespie come amministratore in data 05 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Robert Burdett come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Alexandra Ralph come amministratore in data 05 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Robert Burdett il 25 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Fiona Margaret Gillespie il 25 lug 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smiths Group Plc 2nd Floor Cardinal Place 80 Victoria Street London SW1E 5JL a C/O Smiths Group Plc 4th Floor, 11-12 st James's Square London SW1Y 4LB in data 25 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILLESPIE, Fiona Margaret | Segretario | 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London 4th Floor England | Other | 97576610003 | ||||||
| FURLONGER, Marc | Amministratore | 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London C/O Smiths Group Plc England | England | British | 98322410002 | |||||
| GILLESPIE, Fiona Margaret | Amministratore | 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London C/O Smiths Group Plc England | England | British | 229862900001 | |||||
| BUCHAN, Jennifer Susan | Segretario | Highdown Greenway Road GL56 9BQ Blockley Gloucestershire | British | 32414310001 | ||||||
| MUNFORD, Marina Elizabeth Florence | Segretario | 6 Birch Copse Bricket Wood AL2 3UT St Albans Hertfordshire | British | 10478120001 | ||||||
| PENN, David Alfred | Segretario | 2 Salmons Lane Middleton Cheney OX17 2NF Banbury Oxon | British | 64115230001 | ||||||
| BAYLY, Anthony Edward | Amministratore | 65 Sandelswood End HP9 2AA Beaconsfield Buckinghamshire | British | 57140190001 | ||||||
| BRAIN, Bruce | Amministratore | West Sevington Farmhouse Yatton Keynell SN15 4NB Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 9395440004 | |||||
| BURDETT, Neil Robert | Amministratore | 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London 4th Floor England | England | British | 188620005 | |||||
| DONOVAN, Terence John | Amministratore | 20 Devereux Road SL4 1JJ Windsor Berkshire | Uk | British | 88334080001 | |||||
| EDWARDS, John Ralph | Amministratore | Green Hedges 25 Saint Johns Street RG45 7NJ Crowthorne Berkshire | United Kingdom | British | 60448890001 | |||||
| HARDING, David Alan | Amministratore | Cedar House 22 Plymouth Road B45 8JA Barnt Green Birmingham | England | British | 80124630001 | |||||
| LILLYCROP, David Peter | Amministratore | Canal Cottage HP22 5NS Halton Village Buckinghamshire | American | 32621210001 | ||||||
| MCKEOWN, Matthew Robin | Amministratore | 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London C/O Smiths Group Plc England | England | British | 240492390001 | |||||
| MOORE, Nicholas | Amministratore | The Balfour Chatterpie Lane Combe OX29 8PG Witney Oxfordshire | United Kingdom | British | 30223240001 | |||||
| NORRIS, Guy Mervyn | Amministratore | The Dower House Church Road Snitterfield CV37 0LF Stratford Upon Avon | British | 813530001 | ||||||
| O'BRIEN, Susan Lynn | Amministratore | 180 Longfield Lane Cheshunt EN7 6AQ Waltham Cross Hertfordshire | British | 123851410001 | ||||||
| PENN, David Alfred | Amministratore | 2 Salmons Lane Middleton Cheney OX17 2NF Banbury Oxon | England | British | 64115230001 | |||||
| RALPH, Alexandra | Amministratore | 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London C/O Smiths Group Plc England | England | British | 183196610001 | |||||
| RICHARDSON, Malcolm David, Me | Amministratore | 34 Parkfield Rickmansworth Road Chorleywood WD3 5AZ Rickmansworth Hertfordshire | British | 37287720001 | ||||||
| SAUNDERS, Denis | Amministratore | Lime Tree House 3 Tapster Court Bushwood Lane B94 5PJ Lapworth Warwickshire | British | 7290090001 | ||||||
| SMERDON, Gary Lloyd | Amministratore | 23 The Grove Latimer HP5 1UE Chesham Buckinghamshire | Australian | 10468550001 | ||||||
| WALKER, Denis | Amministratore | 28 Lionel Street BB12 6DY Burnley Lancashire | British | 6240800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di XD COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xdg Limited | 06 apr 2016 | 4th Floor, 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London C/O Smiths Group Plc England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
XD COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Creato il 24 set 1987 Consegnato il 14 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the"moneys and liabilities" (as defined) under the terms of the charge. | |
Brevi particolari (Details as above but please ref to doc M395 and attached scheduel thereto for full details by M107/oct 2/cf). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 24 set 1987 Consegnato il 14 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany to the chargee in respect of the"moneys and liabilities" (as defined) under the terms of the charge. | |
Brevi particolari Floating charge over all the but excludint all book and other debts (as defined) (please refer to M395 and attached schedule thereto for full details ry - M106/oct 28/d). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 22 mag 1987 Consegnato il 09 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a counter indemnity agreemtn dated 31.03.87 and/or this charge | |
Brevi particolari All the business undertaking goodwill & other property both present & future including its unsecured capital for the time being of case communications limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage & deed of postponent | Creato il 22 mag 1987 Consegnato il 09 giu 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a counter indemnity agreement dated 31.03.87 and/or this charge | |
Brevi particolari All that l/h land & buildings situate and lying on the east side of caxton way watford business park watford tns hd 184074 and hd 184073. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 set 1986 Consegnato il 15 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from theco. To national westminster bank PLC as trustee for itself and international westminster bank PLC as those moneys are described in paragraphs 1 to 4 of clause 2OF the mortgage debenture. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery & (trade machinery) goodwill, licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rightsin the nature of copyright and all otherintellectual property rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 set 1986 Consegnato il 15 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due ot to become due from the company to samuel montagu & co limited as trustee for itself and midland bank PLC as those moneys are described in paragraphis (1) to (4) of clause 2 of the mortgage debenture. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery ( & trade machinery) goodwill licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rights in the nature of copyright and all otherintellectual property rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 01 set 1986 Consegnato il 15 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the senwa bank limited as those moneys are described in paragraphs (1) to (4) of clause 2 of the mortgage debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery (including trade machinery) goodwill, licences, patents, patent applications, trademarks, copyrights, rightsin the nature of copyright and all otherintellectual property rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| First legal charge. | Creato il 17 mag 1985 Consegnato il 23 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of a facility letter dated 7/8/84 (as amended by a letter dated 3/5/85. | |
Brevi particolari L/H land situate at caxton way and forming part of the watford business park extension, borough of watford, hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0