DIAMOND H CONTROLS LIMITED

DIAMOND H CONTROLS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIAMOND H CONTROLS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00730330
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    • Noleggio di proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere protette da diritto d'autore (77400) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Menzies Business Recovery Llp Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2014

    12 pagine4.68

    Cessazione della carica di Duncan Dargie Mcdougall come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    17 pagineAR01
    Note
    DataNota
    11 dic 2013This document replaces the AR01 registered on 24/10/2013 as it was not properly delivered

    Indirizzo della sede legale modificato da , C/O Bi Group Plc Barlow Road, Aldermans Green Industrial Estate, Coventry, CV2 2LD in data 04 nov 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Cessazione della carica di Alan Rodger come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Duncan Mcdougall come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 ott 2013

    Stato del capitale al 24 ott 2013

    • Capitale: GBP 9,184,180
    SH01
    Note
    DataNota
    11 dic 2013A replacement AR01 was registered on 11/12/2013

    Cessazione della carica di John Tooke come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 nov 2012

    23 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Unit 1 First Avenue, Maybrook Industrial Estate, Minworth Sutton Coldfield, West Midlands, B76 1BA in data 26 apr 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 nov 2011

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Bi Nominees Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Bi Secretariat Limited come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Bi Secretariat Limited il 04 ott 2011

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Bi Nominees Limited il 04 ott 2011

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Edwin Tooke il 04 ott 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2010

    26 pagineAA

    Nomina di Mr Duncan Dargie Mcdougall come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DIAMOND H CONTROLS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RODGER, Alan Mcintosh
    Methven Drive
    KY7 6QW Glenrothes
    5
    Fife
    Amministratore
    Methven Drive
    KY7 6QW Glenrothes
    5
    Fife
    United KingdomBritishDirector138422370001
    MILES, Tracy
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    British67263360002
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Segretario
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    SUTTON, William Michael
    9 The Russells
    Moseley
    B13 8RT Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    9 The Russells
    Moseley
    B13 8RT Birmingham
    West Midlands
    British38681370001
    WAIN, Stephen Gerrard
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    Segretario
    17 Burton Road
    Twycross
    CV9 3PR Atherstone
    Warwickshire
    British2167290001
    BI NOMINEES LIMITED
    First Avenue
    Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    Unit 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    First Avenue
    Minworth
    B76 1BA Sutton Coldfield
    Unit 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02584246
    103445180002
    COOK, Dean Vernon
    Hawthorn House
    3 St Marys
    NR21 7NZ Colkirk
    Norfolk
    Amministratore
    Hawthorn House
    3 St Marys
    NR21 7NZ Colkirk
    Norfolk
    EnglandBritishFinance Director125206170001
    COOMBE, Steven Andrew
    19 Church Plain
    Loddon
    NR14 6LX Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    19 Church Plain
    Loddon
    NR14 6LX Norwich
    Norfolk
    BritishSales & Marketing Director30975140001
    CORNER, Richard
    The Croft Church Lane
    Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Croft Church Lane
    Averham
    NG23 5RB Newark
    Nottinghamshire
    BritishManaging Director30975150001
    FEDDEN, Anthony Henry
    3 Bramble Way
    Poringland
    NR14 7RT Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    3 Bramble Way
    Poringland
    NR14 7RT Norwich
    Norfolk
    BritishDirector3754670001
    HAYES, Stephen Hedley
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    BritishDirector16415620002
    HENSHAL, Terence Howard
    Tanglewood
    Guestwick
    NR20 5AL Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    Tanglewood
    Guestwick
    NR20 5AL Dereham
    Norfolk
    BritishFinance Director30975160001
    HEWERDINE, Mark Adrian
    34 Springwood
    Taverham
    NR8 6HZ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    34 Springwood
    Taverham
    NR8 6HZ Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector40210920002
    HEWERDINE, Mark Adrian
    14 Glebe Road
    Groby
    LE6 0GT Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    14 Glebe Road
    Groby
    LE6 0GT Leicester
    Leicestershire
    BritishManufacturing Director40210920001
    HOBSON, Andrew Cansfield
    13 Christchurch Road
    NR2 2AE Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    13 Christchurch Road
    NR2 2AE Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishManaging Director64737800001
    HODGE, Philip John
    12 The Paddock
    Lower Boddington
    NN11 6YF Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    12 The Paddock
    Lower Boddington
    NN11 6YF Daventry
    Northamptonshire
    BritishDirector38643360001
    HUTCHINS, Kenneth, Mr.
    Apartment 16
    Littleheath, St Mary's Road
    BR8 7BU Swanley
    Kent
    Amministratore
    Apartment 16
    Littleheath, St Mary's Road
    BR8 7BU Swanley
    Kent
    United KingdomBritishDirector123646570001
    KOTTRITSCH, Robert Louis
    10 The Hollies
    SG17 5BX Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    10 The Hollies
    SG17 5BX Shefford
    Bedfordshire
    EnglandUnited KingdomDirector38890960001
    MACPHERSON, Duncan Campbell Neil
    Glendunning House
    Dunning Glen
    FK14 7LB Dollar
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Glendunning House
    Dunning Glen
    FK14 7LB Dollar
    Clackmannanshire
    ScotlandBritishDirector277190003
    MARTYN, John Hocken
    Wheel Cottage
    Park Road Combs
    IP14 2JS Stowmarket
    Suffolk
    Amministratore
    Wheel Cottage
    Park Road Combs
    IP14 2JS Stowmarket
    Suffolk
    BritishFinance Director45998830001
    MCDOUGALL, Duncan Dargie
    Drumoig
    KY16 0NQ St Andrews
    28 Comerton Place
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    Drumoig
    KY16 0NQ St Andrews
    28 Comerton Place
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishDirector161556820001
    MCDOUGALL, Duncan Dargie
    Comerton Place
    Leuchars
    KY16 0NQ St Andrews
    28
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    Comerton Place
    Leuchars
    KY16 0NQ St Andrews
    28
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishDirector161556820001
    MCMURRAY, William
    20 Cortworth Road
    Eccleshall
    S11 9LP Sheffield
    Amministratore
    20 Cortworth Road
    Eccleshall
    S11 9LP Sheffield
    BritishCompany Director27982740001
    POYNER, Clive Edward
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    17 Isbets Dale
    Taverham
    NR8 6XA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishProduction Director53398970002
    PURDUE, Anthony Christopher
    6 Greaves Close
    WS5 3QT Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    6 Greaves Close
    WS5 3QT Walsall
    West Midlands
    BritishDirector29537770001
    READ, Anthony Bruce
    7 Grange Court
    ST18 0GQ Hixon
    Staffordshire
    Amministratore
    7 Grange Court
    ST18 0GQ Hixon
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector65623570002
    READ, Anthony Bruce
    7 Grange Court
    ST18 0GQ Hixon
    Staffordshire
    Amministratore
    7 Grange Court
    ST18 0GQ Hixon
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector65623570002
    RODGER, Alan Mcintosh
    Methven Drive
    Glenrothes
    KY7 6QW Glenrothes
    5
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    Methven Drive
    Glenrothes
    KY7 6QW Glenrothes
    5
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritishDirector138422370001
    SEDGHI, Bijan Martin
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Sandalls
    944 Warwick Road
    B91 3HW Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector109774110001
    SIMPSON, Simon
    80 Stand Lane
    Radcliffe
    M26 1JU Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    80 Stand Lane
    Radcliffe
    M26 1JU Manchester
    Lancashire
    BritishDirector29252680001
    TOOKE, John Edwin
    180a Drayton High Road
    Drayton
    NR8 6BA Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    180a Drayton High Road
    Drayton
    NR8 6BA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishEngineer30756950002
    WAGSTER, Graham
    26 Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    26 Fletsand Road
    SK9 2AB Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director37423440001
    WAIN, Stephen Gerrard
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    The Nook 35 Main Street
    Norton Juxta Twycross
    CV9 3QA Atherstone
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector2167290002
    WARD, Stephen
    Chimneys
    Fen Street Redgrave
    IP22 1SE Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Chimneys
    Fen Street Redgrave
    IP22 1SE Diss
    Norfolk
    BritishAccountant38616610002
    WARD, Stephen
    14 Kitchener Way
    Shotley Gate
    IP9 1RW Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    14 Kitchener Way
    Shotley Gate
    IP9 1RW Ipswich
    Suffolk
    BritishManager38616610001

    DIAMOND H CONTROLS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Patent mortgage
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 21 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the primary secured liabilities and the secondary secured liabilities
    Brevi particolari
    All right tile and interest in all patents present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 21 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 21 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited,as Security Trustee
    Transazioni
    • 21 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Patent mortgage
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 07 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other group company to the chargee under any documents evidencing the facilities, any of the security documents or in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in all patents and all other inventions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited as Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 07 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 1993
    Consegnato il 07 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the "financing documents" (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co.Limitedthe "Security Trustee"
    Transazioni
    • 07 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DIAMOND H CONTROLS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 ott 2013Inizio della liquidazione
    01 dic 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon James Underwood
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Praticante
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Mark Rodney Newton
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Praticante
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0