DISTINCTIVE CLUBS LIMITED

DISTINCTIVE CLUBS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDISTINCTIVE CLUBS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00730625
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England in data 01 lug 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Extraordinary Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 giu 2013

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Stato del capitale al 24 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled 16/05/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Willits il 19 feb 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 71 Queensway London W2 4QH England in data 15 feb 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2010

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Diane Penfold come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Harry Willits come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Gala Coral Properties Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di DISTINCTIVE CLUBS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Segretario
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3720332
    154706530001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Segretario
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    NOBLE, Michael Jeremy
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    Segretario
    Goathill Farm Well Hill Lane
    Well Hill
    BR6 7QJ Chelsfield
    Kent
    British32786810004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Segretario
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Segretario
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    BENNETT, Michael Daniel
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Amministratore
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    British71518290003
    BORG, Robert George Caesar
    12 Archer Street
    W1V 7UG London
    Amministratore
    12 Archer Street
    W1V 7UG London
    British40722260002
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Amministratore
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    CHALK, Robert Clifford
    1 Mulroy Drive
    GU15 1LX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    1 Mulroy Drive
    GU15 1LX Camberley
    Surrey
    BritainBritish35401590001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    DAVEY, Johann Lesley
    71 Queensway
    W2 4QH London
    Amministratore
    71 Queensway
    W2 4QH London
    British42372810002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    One The Shires
    RG41 4SZ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish21686380003
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Amministratore
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    HARLEY, Susan Boyle
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Threeways Gills Hill Lane
    WD7 8DD Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41384040001
    HASKER, Robert Charles
    12 Archer Street
    W1V 7HG London
    Amministratore
    12 Archer Street
    W1V 7HG London
    British46747960001
    HAYWARD, Patrick Henry
    81 Queensway
    W2 4QY London
    Amministratore
    81 Queensway
    W2 4QY London
    British52032550002
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Amministratore
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    British6467990001
    LLOYD, Thomas Richard
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Little Foxwood 207 The Street
    Capel
    RH5 5ER Dorking
    Surrey
    British66394670001
    LOVE, Andrew Michael
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Amministratore
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British35693230002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    NUNN, Philip Trevor
    79 Queensway
    W2 4QH London
    Amministratore
    79 Queensway
    W2 4QH London
    British48144120002
    PAYNE, Ian Timothy
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Elms 56 Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JZ Solihull
    West Midlands
    British78974110002
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    RAHA, Maryse
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    10 Copse Wood Way
    HA6 2UE Northwood
    Middlesex
    French24036050001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    ROSS, Alan Spencer
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    Amministratore
    1a Palace Gate
    Kensington
    W8 5LS London
    British69823550001
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Amministratore
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003

    DISTINCTIVE CLUBS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 24 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 24 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 20 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 18 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party or any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including 196 piccadilly,london W1V 9LG; NGL770277; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,London Branch,as Security Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fifth supplemental and accession deed
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 11 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (whether actual or contingent) which are at the date of the debenture or thereafter due owing or payable or expressed to be due owing or payable to any creditor (as defined) from or by any obligor (as defined) under or in connection with the facilities agreement,a hedging contract,the deposit agreement and charge on cash deposits or the debenture as such deeds and agreements may be amended or restated in the future
    Brevi particolari
    High street london W3 8BR,the ritz high street aldershot hants,essoldo milburn r oad nothumberland the real property (as defined) all plant machinery and equipment all right title and interest in the investments described in the continuation to form 395,goodwill,book debts.policies of insurance and by way of first floating charge all property and assets of the company for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Agent and Trustee
    Transazioni
    • 11 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 ott 1993
    Consegnato il 19 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 mar 1992
    Consegnato il 14 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    See form 395 ref M709 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The William Hill Group Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 27 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and debenture
    Brevi particolari
    (See form 395 ref M101 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank(Acting as Agent and Trustee for Itself and Each of the "Lenders" as Defined)
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 nov 1991
    Consegnato il 28 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 11TH november 1991
    Brevi particolari
    See form 395 ref M115 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 28 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 01 lug 1991
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the brent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1ST july 1991
    Brevi particolari
    (See doc M148 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 17 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein to the chargee under the terms of this deed
    Brevi particolari
    (See doc M137 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank (As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders as Defined)
    Transazioni
    • 17 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from brent walker limited under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed
    Brevi particolari
    (See doc M168 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC under the terms of a standby facility agreement dated 15/11/90 and this deed
    Brevi particolari
    (See doc M145 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 mar 1991
    Consegnato il 16 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of the facility agreement dated 28/3/91 and this deed
    Brevi particolari
    (See doc M122 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DISTINCTIVE CLUBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 dic 2013Data di scioglimento
    20 giu 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jill Sandford
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Praticante
    Rivermead Court 7 Lewis Court Grove Park
    Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Patrick B Ellward
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    Praticante
    The Poynt 45 Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0