BLD PROPERTIES LIMITED

BLD PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLD PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00732787
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLD PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova BLD PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLD PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASDA PROPERTIES LIMITED04 apr 198504 apr 1985
    ASDA PROPERTY HOLDINGS LIMITED17 ago 196217 ago 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLD PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per BLD PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Bergin come amministratore in data 09 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bruce Michael James come amministratore in data 31 dic 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 29 mar 2021

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Bld Property Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    15 pagineAA

    legacy

    206 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 35 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 41 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018

    16 pagineAA

    legacy

    186 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di BLD PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    CHIA, Swee Ming
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    Segretario
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    British57837290001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Segretario
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British3470530003
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BERGIN, Gavin Joseph
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish251327820001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CHIA, Swee Ming
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    Amministratore
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    BritainBritish57837290001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COHEN, Gerard Phillip
    39 Norrice Lea
    N2 0RD London
    Amministratore
    39 Norrice Lea
    N2 0RD London
    EnglandBritish77787670001
    DAVIDSON, Emanuel Wolfe
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    Amministratore
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    United KingdomBritish3470540001
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Amministratore
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritish35563210002
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Amministratore
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritish35563210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Amministratore
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritish3470530003
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    Amministratore
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    EnglandBritish34366280004
    RANGER, Patrick
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    Amministratore
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    EnglandBritish80021100001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Amministratore
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritish63986410004
    ROSCOE, Antony David
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    Amministratore
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    British12774060001
    ROSE, Jonathan Winston
    44 Park Hall Road
    East Finchley
    N2 9PX London
    Amministratore
    44 Park Hall Road
    East Finchley
    N2 9PX London
    British92654230001
    SCOTT, James Andrew
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    Amministratore
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    British79599370001
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish148183670001
    SMITH, Stephen Paul
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish148183670001
    STEWART, David Purcell
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritish56336720001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLD PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione823907
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BLD PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assurance supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 27 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the original stock (as defined in the above deed of assurance) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance
    Brevi particolari
    Unit 4 thomas road industrial estate london E14 together with all buildings erections fixtures (including tenant's and trade fixtures) fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance, supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds
    Creato il 19 apr 1996
    Consegnato il 26 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee the principal of and interest on the original stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed of assurance
    Brevi particolari
    52 haymarket london SW1 together with all buildings and erections fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed assurance supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds
    Creato il 08 feb 1995
    Consegnato il 09 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the original stock (as defined in the above deed of assurance) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance
    Brevi particolari
    Colindeep works colindeep lane london NW9 together with all buildings and erections and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance and release supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds
    Creato il 28 giu 1994
    Consegnato il 07 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the original stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance and release
    Brevi particolari
    16-90 (even) golders green road,london,NW11.all buildings and erections and fixtures and plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease,rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance
    Creato il 28 gen 1994
    Consegnato il 31 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the original stock (as defined in the deed) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    The wheatley centre,wheatley hall road doncaster t/n's SYK178548,SYK262673 and SYK298837 with all buildings erections fixtures and fittings improvements and additions with the benefit of all existing leases,underleases and tenancy agreements.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance
    Creato il 28 set 1992
    Consegnato il 29 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Friden house 96-101 blackfriars road south title no LN19910.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 29 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance
    Creato il 28 set 1992
    Consegnato il 29 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of title no BK233850.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 29 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Acquisition of property
    Creato il 17 gen 1992
    Acquisito il 31 dic 1991
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    413/423 (odd) wimborne road winton bournemouth.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance
    Creato il 06 dic 1991
    Consegnato il 11 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000,000 10 5/ 16 % first mortgage debenture stock of the company and all other monies intended to be secured
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a 83 marleybone high street london W1 t/n NGL686636 all that f/h property k/a 14/15 quarry street guildford t/n SY571237.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance
    Creato il 31 lug 1990
    Consegnato il 03 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other moneys due or to become due to guardian exchange assurance PLC under this deed.
    Brevi particolari
    4 great james street london WC1 together with all buildings & erections & fixtures (including tenents' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Second supplemental trust deed.
    Creato il 18 lug 1989
    Consegnato il 27 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £21,000,000 10 5116% first mortgage debenture stock 2011 and £25,000,000 10 5/16 % first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies due or to become due to the chargee under this deed
    Brevi particolari
    As regards property and tenure named in doc M293 (see for details) by way of first floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 27 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 04 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold properties k/a 79-81 uxbridge road london WU5 title no mx 16792 and mx 432312 83,85,87 and 89 uxbridge road. London W5 t/no. Ngl 251724 93,93 and 95 uxbridge road london W5. T/no. Mx 267179 2. all rents owing or hereafter to become payable under any insurance of the mortgage property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Republic National Bank of New York
    Transazioni
    • 04 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memorandium of chrge and set-off
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 04 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any moneys (wether of principal interest or otherwise) at any time standing to the credit of the company on any account with republic national bank of new york.
    Persone aventi diritto
    • Republic National Bank of New York.
    Transazioni
    • 04 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Elgal charge by guarantee
    Creato il 01 mar 1989
    Consegnato il 03 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cottesloe property investments limited to the chargee.
    Brevi particolari
    F/H property k/a nos 19 and 21 clarence street cheltenham gloucester. Title no. Gr 747 together with all buildings and erections, fixtures & fittings & fixed plant & machinery (please see doc for details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong & Shanghai Banking Corporation
    Transazioni
    • 03 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1989
    Consegnato il 01 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    195 and 197 wardour street, L.B. of city of westminster t/nos. Ln 122212 ln 10751.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Memorandum of deposit of deed (charge without written instrument)
    Creato il 08 dic 1988
    Consegnato il 19 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45 & 47 shelton street and 15, 17, 19 and 21 endees street (formerly k/a 43, 45,and 47 shelton street and 19A, 21, 23 and 25 endels street).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Deed of assurance supplemental to a trust deed and supplemental trust deed
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 06 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £21,000,000 10 5/16THS percent first mortgage debenture stock 2011 of the company and all other monies due or to become the from the company to the chargee pursuant to 9 trust deed d/d 26/3/86 and a supplemental rust deed dated 7/4/87
    Brevi particolari
    12/16 the traverse, bury st. Edmunds. Together with all buildings and erections and fixtures (including tenant's and trade fixtures and fixtures and fixed plant and machinery).
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchalge Assurance PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assurance supplemental to a trust deed and supplemntal trust deed
    Creato il 29 nov 1988
    Consegnato il 02 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £21,000,000 10 5/6THS per cent first mortgage debenture stock of the company and all other monies due or to become due from the company to guardian royal exchange assurance PLC pursuant to a trust deed dated 26/3/86 and a supplemental trust deed dated 7/4/87
    Brevi particolari
    9/15 fore street, bodmin, cornwall together with all buildings and creditors and fixturers (including tenant's and trade fixtures and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memorandum of deposit of deeds and/or documnets
    Creato il 06 ott 1988
    Consegnato il 11 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As to all deeds, writings, and documents deposited by us (and which we shall have confirmed as beding sublectd to this charge).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 marleybone mews london W1 comprised in land registry t/n ln 80695.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58 queen anne street london W1 comprised in land registry t/n ln 195987.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1988
    Consegnato il 16 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 6,7,8 & 9 snow hill london EC1 t/n ngl 295072. (please see form 395 for full details).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Republic National Bank of New York.
    Transazioni
    • 16 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    Deed of assurance
    Creato il 13 nov 1987
    Consegnato il 25 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Debenture stock of asda property holdings PLC amounting to £21 million 10 5/16 % first mortgage debenture stock 2011 under the terms of a trust deed d/d 26.3.86 and supplemental trust deed d/d 7.4.87
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a colingdeep works, colindeep lane, london and all that l/h property k/a the goldhawk estate london W6.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 01 set 1987
    Consegnato il 16 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The goldhawk estate, london borough of hammersmith & fulham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 25 ago 1987
    Consegnato il 26 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land on the west side of crystal palace road, together with units 1 & 2, 2 crystal palace road, london SE22 and all buildings & fixtues thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0