BLD PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLD PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00732787 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLD PROPERTIES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova BLD PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLD PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ASDA PROPERTIES LIMITED | 04 apr 1985 | 04 apr 1985 |
| ASDA PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 17 ago 1962 | 17 ago 1962 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLD PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLD PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Gavin Bergin come amministratore in data 09 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Bruce Michael James come amministratore in data 31 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 29 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Bld Property Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 15 pagine | AA | ||
legacy | 206 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 35 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 41 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018 | 16 pagine | AA | ||
legacy | 186 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di BLD PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| CHIA, Swee Ming | Segretario | 10 Mount Ephraim Road Streatham SW16 1NG London | British | 57837290001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Segretario | 80 Kingsley Way N2 0EN London | British | 3470530003 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERGIN, Gavin Joseph | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 251327820001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CHIA, Swee Ming | Amministratore | 10 Mount Ephraim Road Streatham SW16 1NG London | Britain | British | 57837290001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COHEN, Gerard Phillip | Amministratore | 39 Norrice Lea N2 0RD London | England | British | 77787670001 | |||||||||
| DAVIDSON, Emanuel Wolfe | Amministratore | 6 Beechworth Close NW3 7UT London | United Kingdom | British | 3470540001 | |||||||||
| DAVIDSON, Gerald Abraham | Amministratore | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | 35563210002 | |||||||||
| DAVIDSON, Gerald Abraham | Amministratore | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | 35563210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 1898090001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Amministratore | 80 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | 3470530003 | |||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| PELTZ, Daniel | Amministratore | 9 Cavendish Avenue St Johns Wood NW8 9JD London | England | British | 34366280004 | |||||||||
| RANGER, Patrick | Amministratore | 2 Park Hill Ealing W5 2JR London | England | British | 80021100001 | |||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||||||
| ROSCOE, Antony David | Amministratore | 54 Fowlers Walk W5 1BG London | British | 12774060001 | ||||||||||
| ROSE, Jonathan Winston | Amministratore | 44 Park Hall Road East Finchley N2 9PX London | British | 92654230001 | ||||||||||
| SCOTT, James Andrew | Amministratore | 13 Fairfield Lane SL2 3BX Farnham Royal Buckinghamshire | British | 79599370001 | ||||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 148183670001 | |||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 148183670001 | |||||||||
| STEWART, David Purcell | Amministratore | The Oast House Best Beech TN5 6JH Wadhurst East Sussex | United Kingdom | British | 56336720001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLD PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bld Property Holdings Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Bld Property Holdings Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BLD PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assurance supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds | Creato il 23 gen 1998 Consegnato il 27 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the original stock (as defined in the above deed of assurance) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance | |
Brevi particolari Unit 4 thomas road industrial estate london E14 together with all buildings erections fixtures (including tenant's and trade fixtures) fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance, supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds | Creato il 19 apr 1996 Consegnato il 26 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee the principal of and interest on the original stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the deed of assurance | |
Brevi particolari 52 haymarket london SW1 together with all buildings and erections fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed assurance supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds | Creato il 08 feb 1995 Consegnato il 09 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the original stock (as defined in the above deed of assurance) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance | |
Brevi particolari Colindeep works colindeep lane london NW9 together with all buildings and erections and fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance and release supplemental to a trust deed and two supplemental trust deeds | Creato il 28 giu 1994 Consegnato il 07 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the original stock (as defined) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies intended to be secured by the said deed of assurance and release | |
Brevi particolari 16-90 (even) golders green road,london,NW11.all buildings and erections and fixtures and plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements for lease,rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 28 gen 1994 Consegnato il 31 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the original stock (as defined in the deed) which amounts to £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Brevi particolari The wheatley centre,wheatley hall road doncaster t/n's SYK178548,SYK262673 and SYK298837 with all buildings erections fixtures and fittings improvements and additions with the benefit of all existing leases,underleases and tenancy agreements. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 28 set 1992 Consegnato il 29 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £46,000,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Friden house 96-101 blackfriars road south title no LN19910. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 28 set 1992 Consegnato il 29 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £46,000,000 & all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land and buildings on the south side of title no BK233850. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Acquisition of property | Creato il 17 gen 1992 Acquisito il 31 dic 1991 Consegnato il 17 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £46,000,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 413/423 (odd) wimborne road winton bournemouth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 06 dic 1991 Consegnato il 11 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £46,000,000 10 5/ 16 % first mortgage debenture stock of the company and all other monies intended to be secured | |
Brevi particolari All that l/h property k/a 83 marleybone high street london W1 t/n NGL686636 all that f/h property k/a 14/15 quarry street guildford t/n SY571237. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 31 lug 1990 Consegnato il 03 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £46,000,000 10 5/16% first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other moneys due or to become due to guardian exchange assurance PLC under this deed. | |
Brevi particolari 4 great james street london WC1 together with all buildings & erections & fixtures (including tenents' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed. | Creato il 18 lug 1989 Consegnato il 27 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £21,000,000 10 5116% first mortgage debenture stock 2011 and £25,000,000 10 5/16 % first mortgage debenture stock 2011 of asda property holdings PLC and all other monies due or to become due to the chargee under this deed | |
Brevi particolari As regards property and tenure named in doc M293 (see for details) by way of first floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 mar 1989 Consegnato il 04 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold properties k/a 79-81 uxbridge road london WU5 title no mx 16792 and mx 432312 83,85,87 and 89 uxbridge road. London W5 t/no. Ngl 251724 93,93 and 95 uxbridge road london W5. T/no. Mx 267179 2. all rents owing or hereafter to become payable under any insurance of the mortgage property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandium of chrge and set-off | Creato il 23 mar 1989 Consegnato il 04 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any moneys (wether of principal interest or otherwise) at any time standing to the credit of the company on any account with republic national bank of new york. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Elgal charge by guarantee | Creato il 01 mar 1989 Consegnato il 03 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from cottesloe property investments limited to the chargee. | |
Brevi particolari F/H property k/a nos 19 and 21 clarence street cheltenham gloucester. Title no. Gr 747 together with all buildings and erections, fixtures & fittings & fixed plant & machinery (please see doc for details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 feb 1989 Consegnato il 01 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 195 and 197 wardour street, L.B. of city of westminster t/nos. Ln 122212 ln 10751. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandum of deposit of deed (charge without written instrument) | Creato il 08 dic 1988 Consegnato il 19 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 45 & 47 shelton street and 15, 17, 19 and 21 endees street (formerly k/a 43, 45,and 47 shelton street and 19A, 21, 23 and 25 endels street). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance supplemental to a trust deed and supplemental trust deed | Creato il 30 nov 1988 Consegnato il 06 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £21,000,000 10 5/16THS percent first mortgage debenture stock 2011 of the company and all other monies due or to become the from the company to the chargee pursuant to 9 trust deed d/d 26/3/86 and a supplemental rust deed dated 7/4/87 | |
Brevi particolari 12/16 the traverse, bury st. Edmunds. Together with all buildings and erections and fixtures (including tenant's and trade fixtures and fixtures and fixed plant and machinery). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance supplemental to a trust deed and supplemntal trust deed | Creato il 29 nov 1988 Consegnato il 02 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £21,000,000 10 5/6THS per cent first mortgage debenture stock of the company and all other monies due or to become due from the company to guardian royal exchange assurance PLC pursuant to a trust deed dated 26/3/86 and a supplemental trust deed dated 7/4/87 | |
Brevi particolari 9/15 fore street, bodmin, cornwall together with all buildings and creditors and fixturers (including tenant's and trade fixtures and fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Memorandum of deposit of deeds and/or documnets | Creato il 06 ott 1988 Consegnato il 11 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari As to all deeds, writings, and documents deposited by us (and which we shall have confirmed as beding sublectd to this charge). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 set 1988 Consegnato il 27 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 10 marleybone mews london W1 comprised in land registry t/n ln 80695. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 set 1988 Consegnato il 27 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 58 queen anne street london W1 comprised in land registry t/n ln 195987. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 mag 1988 Consegnato il 16 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a 6,7,8 & 9 snow hill london EC1 t/n ngl 295072. (please see form 395 for full details).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assurance | Creato il 13 nov 1987 Consegnato il 25 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Debenture stock of asda property holdings PLC amounting to £21 million 10 5/16 % first mortgage debenture stock 2011 under the terms of a trust deed d/d 26.3.86 and supplemental trust deed d/d 7.4.87 | |
Brevi particolari All that f/h property k/a colingdeep works, colindeep lane, london and all that l/h property k/a the goldhawk estate london W6. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 01 set 1987 Consegnato il 16 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The goldhawk estate, london borough of hammersmith & fulham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 25 ago 1987 Consegnato il 26 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being land on the west side of crystal palace road, together with units 1 & 2, 2 crystal palace road, london SE22 and all buildings & fixtues thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0