DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED

DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00733686
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DISPLAYMATICS LIMITED28 ago 196228 ago 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 11 gen 2022

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Zane Cedomir Mersich il 22 set 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales a Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 13 lug 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England a Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB in data 16 mar 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Neil Paramore come segretario in data 28 gen 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Neil Paramore come amministratore in data 28 gen 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come segretario in data 28 gen 2020

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Andrew Mark Glennon come amministratore in data 28 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 11 giu 2016

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Segretario
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960890001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Amministratore
    South Road
    Bridgend Indsutrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    PARAMORE, Neil
    Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209557760001
    SHEERIN, Clare
    8 College Place
    SO15 2FF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    8 College Place
    SO15 2FF Southampton
    Hampshire
    British116312770001
    WILLSON, Michael Eric Anthony
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    British7439200002
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965170002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Segretario
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    GUYER, John Hugh
    Thatched Cottage
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Thatched Cottage
    Greatbridge
    SO51 0HB Romsey
    Hampshire
    British35529950003
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Amministratore
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001
    WILLSON, Michael Eric Anthony
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    8 Chestnut Close
    Chandlers Ford
    SO53 3HH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish7439200002

    Chi sono le persone con controllo significativo di DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06 apr 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05382157
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DISPLAYMATICS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 17 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 17 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ott 2006
    Consegnato il 19 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 feb 2000
    Consegnato il 23 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 bellvue road southampton. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 apr 1999
    Consegnato il 13 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 1 the broadway portswood southampton hampshire t/ HP281708. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 gen 1997
    Consegnato il 23 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 61 commercial road totton southampton hampshire t/no hp 407319 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ago 1993
    Consegnato il 26 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £86,450 and all other moneys due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 the broadway portswood southampton hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Lordsvale Finance PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1992
    Consegnato il 08 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    30 and 32 high road,swaythling,southampton,hampshire.t/nos. Hp 178279 and hp 129297 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 1987
    Consegnato il 17 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h and l/h property k/a 208 burgess road, southampton and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 ott 1983
    Consegnato il 17 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    32/34 beech road millbrook southampton t/n:- HP147635 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 1983
    Consegnato il 17 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    110A bevois valley road, southampton t/n:- HP171846. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 1983
    Consegnato il 10 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H eatamasan cafe and adjaning premises at 1A & 1B weston lane woolston, southampton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ago 1980
    Consegnato il 10 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 27,000
    Brevi particolari
    32/34 beech road, millbrook southampton, hampshire 110A bevois valley road southampton, hampshire.
    Transazioni
    • 10 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral legal charge
    Creato il 03 mar 1980
    Consegnato il 10 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 7,000.00
    Brevi particolari
    110A bevois valley rd southampton, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Brettan Mortgage Investments (Hampshire) LTD
    Transazioni
    • 10 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Collateral legal charge
    Creato il 03 mar 1980
    Consegnato il 10 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 7,000.00
    Brevi particolari
    23/34 beech rd, millbrook southampton, hampshire T. no. HP147635.
    Persone aventi diritto
    • Brettan Mortgage Investments (Hampshire) LTD
    Transazioni
    • 10 mar 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0