REG VARDY (MML) LIMITED

REG VARDY (MML) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREG VARDY (MML) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00736438
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REG VARDY (MML) LIMITED?

    • Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova REG VARDY (MML) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REG VARDY (MML) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAGNETIC MOTORS LIMITED04 gen 199604 gen 1996
    GLOBAL OVERLAND LIMITED09 giu 198809 giu 1988
    HIGHFIELDS TRAVEL BUREAU LIMITED27 set 196227 set 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di REG VARDY (MML) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per REG VARDY (MML) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    10 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 dic 2020

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Reg Vardy (Thm) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di REG VARDY (MML) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishSolicitor110894220002
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector229010610001
    BELL, Richard William
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    British1124760001
    BRINE, Jason Andrew
    The Old Granary South Farm Court
    Sandhutton
    YO7 4RY Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    The Old Granary South Farm Court
    Sandhutton
    YO7 4RY Thirsk
    North Yorkshire
    British67811740002
    LAUGHLIN, Fiona Elizabeth
    23 The Crescent
    NE26 2JG Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    23 The Crescent
    NE26 2JG Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British1417030001
    RAWNSLEY, Patrick James
    Stonecroft, 2 Lakeside Close
    Ilkley
    LS29 0AG Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Stonecroft, 2 Lakeside Close
    Ilkley
    LS29 0AG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary108571170001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector41559790001
    WILLIAMS, Julie Suzanne
    14 Nightingale Close
    Spinnakers Reach
    TS26 0HL Hartlepool
    Cleveland
    Segretario
    14 Nightingale Close
    Spinnakers Reach
    TS26 0HL Hartlepool
    Cleveland
    British105112860001
    BARR, John Malcolm
    Kirkby House
    Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kirkby House
    Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChairman33219550001
    BARR, Nicholas Stuart
    Mouse Hall
    Galphay
    HG4 3NT Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Mouse Hall
    Galphay
    HG4 3NT Ripon
    North Yorkshire
    BritishDirector53565740001
    BARR, Robert Adam
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director28813320001
    BARR, Stuart Alan
    The Royal Hunting Lodge
    Shipton
    YO6 1BD Beningborough
    York
    Amministratore
    The Royal Hunting Lodge
    Shipton
    YO6 1BD Beningborough
    York
    BritishGroup Managing Director509420001
    BELL, Richard William
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director1124760001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector2652610013
    FORRESTER, Robert Thomas
    38 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    38 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishFinance Director76716700002
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant55127120002
    HEINZ, Stephen Karl
    69 Swillington Lane
    Swillington
    LS26 8QF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    69 Swillington Lane
    Swillington
    LS26 8QF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector29394110001
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Amministratore
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant148034310003
    MCALOON, William Gerard
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    Amministratore
    10 Jacks View
    West Kilbride
    KA23 9HX Ayshire
    Ayrshire
    BritishFinance Director108756350001
    MURRAY, Gerard Thomas
    9 Southlands
    NE30 2QS Tynemouth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    9 Southlands
    NE30 2QS Tynemouth
    Tyne & Wear
    BritishDirector87695440001
    POTTS, Graeme John
    Ashleigh Ashbrooke Range
    SR2 7TP Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Ashleigh Ashbrooke Range
    SR2 7TP Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishDirector916400001
    SMALL, Brian Michael
    Laithe Croft
    Totties Lane
    HD1 1UL Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Laithe Croft
    Totties Lane
    HD1 1UL Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishCompany Director45198750001
    SPETCH, Paul Anthony
    Rivelin Common Lane
    Warthill
    YO19 5XL York
    Amministratore
    Rivelin Common Lane
    Warthill
    YO19 5XL York
    EnglandBritishFinancial Director51421190001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector41559790001
    VARDY, Peter, Sir
    Rainton House
    Middle Rainton
    DH4 6PJ Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Rainton House
    Middle Rainton
    DH4 6PJ Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector12048420003
    WIDDOWS, Angela Hermione, The Hon
    Home Farm
    Sand Hutton
    YO41 1JZ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Home Farm
    Sand Hutton
    YO41 1JZ York
    North Yorkshire
    BritishCompany Director94121160001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    BritishChairman6529580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REG VARDY (MML) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Reg Vardy (Thm) Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2825899
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    REG VARDY (MML) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 mag 2013
    Consegnato il 22 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 22 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2009
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0