MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED

MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00741999
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARCRO-OLYMPIC STRANDERS LIMITED26 nov 196226 nov 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Antony Storey come amministratore in data 29 nov 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr André Rahmen come amministratore in data 25 nov 2013

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen David Lidgate come amministratore in data 25 nov 2013

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Antony Storey il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Antony Storey il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LIDGATE, Stephen David
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish183151940001
    RAHMEN, André
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Beresford Way
    S41 9FG Chesterfield
    The Bridge Business Centre
    Derbyshire
    England
    GermanyGerman183153740001
    NICKLIN, George
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    Segretario
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    British28873360001
    ROBSON, David
    2 Spire Hollin
    SR8 1DA Peterlee
    County Durham
    Segretario
    2 Spire Hollin
    SR8 1DA Peterlee
    County Durham
    British53835800001
    BREME, Harald
    Maarweg 16
    D-5100 Aachen
    Germany
    Amministratore
    Maarweg 16
    D-5100 Aachen
    Germany
    German29332200002
    CAHILL, Terence
    5 Mallard Way
    CF36 3TS Porthcawl
    Mid-Glamorgan
    Amministratore
    5 Mallard Way
    CF36 3TS Porthcawl
    Mid-Glamorgan
    British28873380001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CHARLES, Nigel Alan
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    1 Midfields
    School Aycliffe
    DL5 6QJ Newton Aycliffe
    County Durham
    British30529170001
    ERKES, Klaus Friedrich
    Auf Der Alm 10a
    Roetgen D-52159
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Auf Der Alm 10a
    Roetgen D-52159
    FOREIGN Germany
    German60961460001
    GRAEFE, Joachim, Dr
    Sonnenhang 7b
    Schwerte
    D-58239
    Germany
    Amministratore
    Sonnenhang 7b
    Schwerte
    D-58239
    Germany
    German105757030001
    NICKLIN, George
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    Amministratore
    25 Buttermere
    DL16 6UD Spennymoor
    County Durham
    United KingdomBritish28873360001
    PAMPLIN, John Warner, Dr
    Kirklees
    Hamsterley
    DL13 3PP Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    Kirklees
    Hamsterley
    DL13 3PP Bishop Auckland
    County Durham
    British9292930001
    PARKES, John
    19 Wardles Lane
    Great Wyrley
    WS6 6DX Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    19 Wardles Lane
    Great Wyrley
    WS6 6DX Walsall
    West Midlands
    British55620660001
    PEIRSON, James Geoffrey
    17 Lindom Avenue
    DH3 3PP Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    17 Lindom Avenue
    DH3 3PP Chester Le Street
    County Durham
    British53835710001
    STOREY, Paul Antony
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    Amministratore
    1 Henson Close
    South Church Enterprise Park
    DL14 6WA Bishop Auckland
    Durham
    United KingdomBritish53835780003
    TOMLINSON, Walter Murray
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    Amministratore
    Letterbox Farm
    Pratthall Calthorpe
    S42 7AZ Chesterfield
    British1961890001
    WETZELS, Walter
    Maarweg 12
    D-5100 Aachen
    Germany
    Amministratore
    Maarweg 12
    D-5100 Aachen
    Germany
    Belgian31753130001

    MARSHALL RICHARDS BARCRO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 08 gen 1991
    Consegnato il 10 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or wmt holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Prospect house, fir tree crook county durham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 14 lug 1989
    Consegnato il 31 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from morgan 85 LTD and/or rails 84 LTD and/or power and central systems LTD and/or wmt holdings LTD and/or lubewell LTD and/or limited and/or strategic maintenance services LTD and/or beals limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any accounts of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 22 set 1988
    Consegnato il 27 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from wmt holdings limited and/or beaver 84 limited and/or rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or morgan 85 limited and/or power & coutron systems limited and/or lubeswell limited on any account whatsoever to the chargee
    Brevi particolari
    All monies to the credit of any accounts of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 05 mar 1988
    Consegnato il 23 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from wmt holdings LTD and/or beaver 84 LTD and/or rails 84 LTD and/or murhan associates LTD and/or morgan 85 LTD and/or power & control systems LTD. To the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies due now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 09 apr 1987
    Consegnato il 15 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rails 84 limited and/or murhan associates limited and/or beaver 84 limited and/ or morgan 85 limited and/or wmt holdings limited to the governor and company of the bank of scotland on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 09 apr 1987
    Consegnato il 15 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future as specified in attached schedule which also contains covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charges and must be read as one with the charges (please see doc).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 mag 1985
    Consegnato il 14 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book and other debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 12 giu 1984
    Consegnato il 20 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from wmt holdings limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to a loan agreement dated 12 june 1984
    Brevi particolari
    First legal mortgage the real property prospect house fir tree crook co durham first fixed charge (a) all real property (b) equipment fittings fixtures and furnishings (c) the goodwill and connections of the business (d) all book debts and other debts (e) plant and machinery now or from time to time owned by the company fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transazioni
    • 20 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0