GIBBS NEWS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGIBBS NEWS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00744680
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GIBBS NEWS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GIBBS NEWS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GIBBS NEWS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SURRIDGE NEWSAGENTS LIMITED11 apr 198611 apr 1986
    SURRIDGE,DAWSON & COMPANY(PRODUCTIONS)LIMITED19 dic 196219 dic 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di GIBBS NEWS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al23 feb 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per GIBBS NEWS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 23 feb 2019

    3 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 10 set 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:powers of liquidators
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 ago 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 ago 2019

    • Capitale: GBP 1.000000
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 13/08/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 24 feb 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 ott 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    158 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Cessazione di Gibbs Newsagents Limited come persona con controllo significativo il 06 feb 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Tesco Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 feb 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di Tesco Services Limited come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GIBBS NEWS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    British204754740001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    BURROWS, Patrick James
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    British86778310001
    COWELL, Martin William
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    British1614020001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    Segretario
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Segretario
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    BODDICE, Stephen
    Churchill Old Farm
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Churchill Old Farm
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish1673770001
    BURROWS, Patrick James
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    British86778310001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CRELLIN, David
    191 Worcester Road
    Hagley
    DY9 0PR Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    191 Worcester Road
    Hagley
    DY9 0PR Stourbridge
    West Midlands
    British31677030002
    GIBBONS, Colin Howard
    33 Abbotsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    33 Abbotsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    British61993880001
    GORDON, Timothy Leigh
    2 Sandown Drive
    Halebarns
    WA15 0BA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    2 Sandown Drive
    Halebarns
    WA15 0BA Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish2900860001
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    EnglandBritish57637410003
    HOLMES, Colin Peter
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish86778500001
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LLOYD, Jonathan Mark
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish160028560001
    MCCARTHY, James John
    Broadview House
    34 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Broadview House
    34 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British2426350005
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MOORE, Dean
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    Amministratore
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    British94541520001
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    Amministratore
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    British98194710001
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish148079740001
    O'NEILL, William Patrick
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British106806380001
    PENFOLD, Julia
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    Amministratore
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    British67318640001
    PURDY, Geoffrey
    56 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    56 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British39918970001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    SMITH, Bryan Robin Geoffrey Gilbert
    Queen Annes
    TN17 1BN Goudhurst
    Kent
    Amministratore
    Queen Annes
    TN17 1BN Goudhurst
    Kent
    British34819420002
    SMITH, Richard John
    101 Dropmore Road
    Burnham
    SL1 8AY Slough
    Amministratore
    101 Dropmore Road
    Burnham
    SL1 8AY Slough
    British38475260001
    THRELFALL, Kevin Patrick
    Perton House Pattingham Road
    Perton
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Perton House Pattingham Road
    Perton
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1614060001
    TURNER, David
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish109813430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GIBBS NEWS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    06 feb 2018
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00243011
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2159775
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GIBBS NEWS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    First guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 1999
    Consegnato il 08 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and each and every liability now or in the future due and owing by each company (as defined therein) to the chargee under or pursuant to the finance documents and/or the banks bilateral facilities
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 08 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A guarantee and debenture
    Creato il 28 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the group companies (as defined in the facilities agreement) to (I) each bank (as defined in the facilities agreement) pursuant to the banks' bilateral facilities and/or (ii) to each beneficiary (as defined) pursuant to the senior finance documents (all as defined)
    Brevi particolari
    F/H unit 1,apex road brownhills,west midlands WM230532;f/h north west side of pelsall road brownhills,west midlands t/no.WM80733;f/h east side of apex road brownhills,west midlands t/no.WM385696.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37 kings road,chatham,kent.t/no.K337619.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19 new road,hanworth,hounslow,london borough of hounslow.t/no.ngl 369034.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41 egremont road,bearsted,kent.t/no.K347432.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    9 woburn court,vincent road,luton,bedfordshire.t/no.BD45427.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 arnal crescent,wandsworth,london borough of wandsworth.t/no.sgl 441233.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    10 woburn court,vincent road,luton,bedfordshire.t/no.BD44799.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3 station parade,elm park,hornchurch,london borough of havering.t/no.egl 72257.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18 twisden road,watermeadow estate,east malling,kent.t/no.K685170.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20 twisden road,east malling,kent.t/no.K685171.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    124 little pynchons,harlow,essex.t/no.ex 156108.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 27 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Durgates stores,durgates,wadhurst,east sussex.t/no.ESX136681.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 1992
    Consegnato il 12 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M637C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:86/86A high street,uckfield,east sussex.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M525C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:shop 3 & flat 7,grove park shopping centre,gadby road, sittingbourne,kent.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M524C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:shop 6,maisonette 32 & garage 21,grover walk,corrington town centre,essex.by way of assignment: the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M523C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:36/36A north parade,chessington,surrey.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M522C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreemment dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:134 & 152 the gossamers,meriden estate,watford,hertfordshire.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M521C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:31 egremont road,bearsted,maidstone,kent.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M520C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:434 hedgemans road,dagenham,l/b of barking & dagenham. By way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M519C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:9 sedlescombe road north,st leonards,east sussex.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M518C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:88/88A high street,uckfield,east sussex.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M517C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:129 hersham road,walton-on-thames,surrey.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights and claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M516C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the banks as defined in the banking facility agreement pursuant to the terms of the guarantee & debenture,the banking facility agreement dated 15TH may 1989 and the overdraft letter of even date.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:69/71 crescent road,kingston-upon-thames,l/b of kingston-upon-thames.by way of assignment:the benefit to the borrower of all rights & claims to which the company is now or may hereafter become entitled in relation to the property. Please see M515C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GIBBS NEWS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 ago 2019Inizio della liquidazione
    12 gen 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0