G3 INVESTMENTS LIMITED

G3 INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG3 INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00746257
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G3 INVESTMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WHITTLE INVESTMENT SERVICES LIMITED08 set 199508 set 1995
    G. & C. WHITTLE HOLDINGS LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    MITRO ANODISING LIMITED08 gen 196308 gen 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 81 Burton Road Derby Derbyshire DE1 1TJ a Suite a 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS in data 04 dic 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 nov 2017

    LRESSP

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ott 2015

    Stato del capitale al 22 ott 2015

    • Capitale: GBP 878,003
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 878,003
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Campbell Whittle il 16 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Massey Whittle il 16 set 2014

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 21 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MINOGUE, Gillian Mary
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6 Carisbrooke Avenue
    England
    Segretario
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6 Carisbrooke Avenue
    England
    188447670001
    MINOGUE, Gillian Mary
    Carisbrooke Avenue
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    Carisbrooke Avenue
    Mapperley Park
    NG3 5DT Nottingham
    6
    United Kingdom
    BritishCompany Director44177270003
    WHITTLE, Stephen Campbell
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    Amministratore
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    United KingdomBritishDirector8325760005
    WHITTLE, Susan Massey
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    Amministratore
    Oakhill House
    32 Park Terrace
    NG1 5DN Nottingham
    Flat 2
    England
    United KingdomBritishCompany Director8325770006
    HAMMOND, Christopher John
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    Segretario
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    British56802710001
    HUGHES, John Richard Hal
    Ivy Lodge
    2 Hallfields
    NG12 4AA Edwalton
    Nottinghamshire
    Segretario
    Ivy Lodge
    2 Hallfields
    NG12 4AA Edwalton
    Nottinghamshire
    British56860280001
    HAMMOND, Christopher John
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    17 Rock Hill Gardens
    NG18 2JP Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishAccountant56802710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di G3 INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    DE1 1TJ Derby
    81 Burton Road
    Derbyshire
    England
    06 apr 2016
    DE1 1TJ Derby
    81 Burton Road
    Derbyshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02469950
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    G3 INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 set 2003
    Consegnato il 30 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Apartment A24 on second floor of arundel house, 552 kings road, london SW10 to be known as blore house, coleridge gardens, kings road, london SW10 0RB,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 12 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 226 derby road nottingham t/n NT65710. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 8 clumber crescent north the park nottingham; NT22698. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1997
    Consegnato il 15 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land on the south side of little tennis street nottingham title number NT295793. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on the south west side of high church street and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on the north side of kingsbury road erdington and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on the east side of hucknall lane bulwell and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a daybrook house monton road eccles manchester and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a daybrook house hucknal lane bulwell and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 1995
    Consegnato il 26 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 72 maid marian way & newdigate house, castle gate, nottingham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 set 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 mag 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Daybrook house, hucknall lane, bulwell, nottinghamshire t/no. NT212140 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Daybrook house, monton road, eccles, manchester t/no. GM481630 and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at ollerton road, arnold, nottinghamshire, t/no. NT159220 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on west side of kingsbury road, eslington, W.midlands t/no. WM7473 and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at cockcliffe farm, arnold, nottinghamshire t/no. NT261915 and/or proceeds of sale. Floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 ott 1988
    Consegnato il 14 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings at 170A monton road monton eccles manchester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the west of hermitage lane mansfield nottinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises in hucknall lane bulwell, nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 set 1983
    Consegnato il 26 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land containing 18.63 acres. Comprising enclosure numbers 3385 and 3667 on the ordnance survey map at ollerton rd, arnold, nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 mag 1983
    Consegnato il 02 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 giu 1981
    Consegnato il 22 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 14.5 acres approx land at cockliffe hill farm arnold nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 giu 1981
    Consegnato il 22 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H and premises 944/952 kingsbury road erdington birmingham title no. Wm 7473.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 26 giu 1980
    Consegnato il 03 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat e top floor 15 cleveland square. London W.2. title no ln 69566 together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 mar 1980
    Consegnato il 31 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises at nottingham road, daybrook, nottingham together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    G3 INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 apr 2019Data di scioglimento
    06 nov 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Adrian David Allen
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praticante
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0