CHEMRING EUROPE LIMITED

CHEMRING EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHEMRING EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00746603
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHEMRING EUROPE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARKWAY NO 4 LIMITED18 apr 200718 apr 2007
    MCMURDO LIMITED25 set 198925 set 1989
    MCMURDO INSTRUMENT COMPANY LIMITED(THE)11 gen 196311 gen 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 03 feb 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 nov 2022

    • Capitale: GBP 24,156,245
    3 pagineSH01

    Memorandum e Statuto

    6 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    11 pagineMA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Legal Director43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Segretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    British3801050001
    ASHER, Kenneth Robert
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director121877530001
    AVERY, John Leonard
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director82512570001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    BritishChairman18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector1525670001
    DERBYSHIRE, Peter Walter
    Red Post Farm
    Red Post Lane
    SP11 8DA Andover
    Hants
    Amministratore
    Red Post Farm
    Red Post Lane
    SP11 8DA Andover
    Hants
    BritishManager31574890001
    EVANS, David Roger
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    Yoxhall Lodge
    10 Worsley Road
    PO5 3DY Southsea
    Hampshire
    EnglandBritishChief Executive4471420003
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCompany Director188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Amministratore
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    BritishFinance Director & Company Sec85421380001
    HAYTER, Timothy William
    7 Salters Acres
    Stockbridge Road
    SO22 5JW Winchester
    Amministratore
    7 Salters Acres
    Stockbridge Road
    SO22 5JW Winchester
    BritishChief Operating Officer78917440003
    HELLYAR, Stuart Thomas
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Controller109868650001
    HELME, Michael John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishProfessional Engineer91910030002
    HILL, Robert Seamus
    Heathwood 6 Ranvilles Lane
    PO14 3DS Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Heathwood 6 Ranvilles Lane
    PO14 3DS Fareham
    Hampshire
    EnglandBritishManagin Director59194350001
    HOFFMAN, Christopher Paul
    20 Hispano Avenue
    Whiteley
    PO15 7DS Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    20 Hispano Avenue
    Whiteley
    PO15 7DS Fareham
    Hampshire
    BritishTechnical Director67353960001
    JAMES, Ben Luke
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Chemring House 1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant136637830001
    LYNN, John James
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    House On The Corner
    Cricklade Street, Poulton
    GL7 5HW Cirencester
    Gloucestershire
    BritishManaging Director69883500001
    MULLINS, Gary
    8c Langstone Avenue
    PO9 1RU Havants
    Hampshire
    Amministratore
    8c Langstone Avenue
    PO9 1RU Havants
    Hampshire
    EnglandBritishBusiness Director Marine Produ102753040001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive103085690002
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    SMITH, Brian John
    Haystacks 2 St Albans Close
    Bishopdown Farm
    SP1 3FN Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Haystacks 2 St Albans Close
    Bishopdown Farm
    SP1 3FN Salisbury
    Wiltshire
    BritishManager57938750001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector42825970001
    WILLINGHAM, Geoffrey Charles
    64 New Forest Drive
    SO42 7QW Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    64 New Forest Drive
    SO42 7QW Brockenhurst
    Hampshire
    BritishManager31574880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHEMRING EUROPE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione86662
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CHEMRING EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 set 2010
    Consegnato il 13 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 30 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 15 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 nov 2007
    Consegnato il 20 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Noteholders and the Purchasers)
    Transazioni
    • 20 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 15 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 14 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 02 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over book debts
    Creato il 06 dic 1994
    Consegnato il 14 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all monies which it may receive in respect of such debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 06 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 ott 1990
    Consegnato il 05 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 1990
    Consegnato il 05 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0