CHEMRING EUROPE LIMITED
Panoramica
Nome della società | CHEMRING EUROPE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00746603 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHEMRING EUROPE LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CHEMRING EUROPE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHEMRING EUROPE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PARKWAY NO 4 LIMITED | 18 apr 2007 | 18 apr 2007 |
MCMURDO LIMITED | 25 set 1989 | 25 set 1989 |
MCMURDO INSTRUMENT COMPANY LIMITED(THE) | 11 gen 1963 | 11 gen 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHEMRING EUROPE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHEMRING EUROPE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 03 feb 2023
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 nov 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 6 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 11 pagine | MA | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2021 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHEMRING EUROPE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Segretario | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | Company Secretary | 43855640011 | |||||
ELLARD, Sarah Louise | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Segretario | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Segretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Segretario | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
ASHER, Kenneth Robert | Amministratore | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 121877530001 | ||||
AVERY, John Leonard | Amministratore | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 82512570001 | ||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Amministratore | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
BOWERS, Steven John | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
CLEARY, Michael John | Amministratore | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
DERBYSHIRE, Peter Walter | Amministratore | Red Post Farm Red Post Lane SP11 8DA Andover Hants | British | Manager | 31574890001 | |||||
EVANS, David Roger | Amministratore | Yoxhall Lodge 10 Worsley Road PO5 3DY Southsea Hampshire | England | British | Chief Executive | 4471420003 | ||||
FLOWERS, Michael James | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
GIBBS, Raymond John | Amministratore | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | Finance Director & Company Sec | 85421380001 | |||||
HAYTER, Timothy William | Amministratore | 7 Salters Acres Stockbridge Road SO22 5JW Winchester | British | Chief Operating Officer | 78917440003 | |||||
HELLYAR, Stuart Thomas | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Financial Controller | 109868650001 | ||||
HELME, Michael John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | England | British | Professional Engineer | 91910030002 | ||||
HILL, Robert Seamus | Amministratore | Heathwood 6 Ranvilles Lane PO14 3DS Fareham Hampshire | England | British | Managin Director | 59194350001 | ||||
HOFFMAN, Christopher Paul | Amministratore | 20 Hispano Avenue Whiteley PO15 7DS Fareham Hampshire | British | Technical Director | 67353960001 | |||||
JAMES, Ben Luke | Amministratore | Chemring House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 136637830001 | ||||
LYNN, John James | Amministratore | House On The Corner Cricklade Street, Poulton GL7 5HW Cirencester Gloucestershire | British | Managing Director | 69883500001 | |||||
MULLINS, Gary | Amministratore | 8c Langstone Avenue PO9 1RU Havants Hampshire | England | British | Business Director Marine Produ | 102753040001 | ||||
PAPWORTH, Mark Harry | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
PRICE, David John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
SMITH, Brian John | Amministratore | Haystacks 2 St Albans Close Bishopdown Farm SP1 3FN Salisbury Wiltshire | British | Manager | 57938750001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Amministratore | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 | ||||
WILLINGHAM, Geoffrey Charles | Amministratore | 64 New Forest Drive SO42 7QW Brockenhurst Hampshire | British | Manager | 31574880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHEMRING EUROPE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemring Group Plc | 30 giu 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CHEMRING EUROPE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 24 set 2010 Consegnato il 13 ott 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 19 nov 2009 Consegnato il 30 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 12 nov 2007 Consegnato il 20 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 05 feb 2001 Consegnato il 14 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 22 dic 1997 Consegnato il 02 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over book debts | Creato il 06 dic 1994 Consegnato il 14 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all monies which it may receive in respect of such debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 29 apr 1993 Consegnato il 06 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 19 ott 1990 Consegnato il 05 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding uncalled capital those mentioned above). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 ott 1990 Consegnato il 05 nov 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0