ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00747594 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Exchequer Court 33 St Mary Axe EC3A 8AA London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FLAGSTONE SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED | 04 mag 2010 | 04 mag 2010 |
| MARLBOROUGH UNDERWRITING AGENCY LIMITED | 30 dic 1995 | 30 dic 1995 |
| BARDER & MARSH LIMITED | 20 dic 1991 | 20 dic 1991 |
| BARDER & MARSH SERVICES LIMITED | 22 gen 1963 | 22 gen 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Dewey come amministratore in data 31 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Charles Thoresby Pawson come amministratore in data 31 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy Edward Cadle come amministratore in data 31 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Alexander Haggerston Gadsden Cartwright come amministratore in data 02 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor 1 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7AA a Exchequer Court 33 st Mary Axe London EC3A 8AA in data 26 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di James Alexander Haggerston Gadsden Cartwright come amministratore in data 04 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Janice Marie Hamilton come amministratore in data 28 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lynsey Jane Cross come amministratore in data 25 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Simon Wilson Hall come segretario in data 25 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Maxell Percy Taylor come amministratore in data 07 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geradus Maria Van Loon come amministratore in data 07 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Philip Hulse come amministratore in data 07 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Adam Campbell Barker come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADLE, Jeremy Edward | Amministratore | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 121806600001 | |||||
| DEWEY, Peter | Amministratore | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 190721330001 | |||||
| BARDER, Peter Donald | Segretario | 29 East Common AL3 7NG Redbourne Hertfordshire | British | 52783880001 | ||||||
| D'ARCY, Anthony Richard Hugh | Segretario | Bourne House 10 Sandrock Hill Road GU10 4NS Farnham Surrey | British | 60023430001 | ||||||
| EGGLESTON, Hugh Patrick | Segretario | 9 Cicada Road SW18 2NN London | British | 30892130002 | ||||||
| HALL, Andrew Simon Wilson | Segretario | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | 186606190001 | |||||||
| MACDOWALL, Iain Falconer | Segretario | 31 Liskeard Gardens Blackheath SE3 0PE London | British | 209471330001 | ||||||
| MCAULEY, David Charles | Segretario | 11 Brook Gardens KT2 7ET Kingston Upon Thames Surrey | British | 28731100001 | ||||||
| ALLEN, Leslie Francis | Amministratore | Birch House 35 Birch Lane CM4 9NA Stock Essex | England | British | 74796160001 | |||||
| ARMSTRONG, Philip Anthony Christopher | Amministratore | Prinkle Farm House Prinkle Lane Bodle Street Green BN27 4UD Hailsham East Sussex | England | British | 141228360001 | |||||
| BAK, Andrew Roman | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 126790290001 | |||||
| BARDER, John Herbert | Amministratore | Corner Cottage Cedar Road GU22 0JJ Woking Surrey | British | 28045730001 | ||||||
| BARDER, Peter Donald | Amministratore | 29 East Common AL3 7NG Redbourne Hertfordshire | British | 52783880001 | ||||||
| BARDER, Samuel Hugh Leonard | Amministratore | St Johns House RG25 1NW Odiham Hampshire | British | 28045720001 | ||||||
| BARDER, Simon Hugh | Amministratore | Chesters The Street Eversley RG27 0PJ Basingstoke Hampshire | British | 28731110002 | ||||||
| BARKER, Adam Campbell | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 62286820001 | |||||
| BARNES, Jonathan David Patrick | Amministratore | 7 Priory Walk SW10 9SP London | British | 65351030001 | ||||||
| BAUGH, Andrew Peter | Amministratore | 17 Blenheim Close CM21 0BE Sawbridgeworth Hertfordshire | England | British | 94103330001 | |||||
| BLOXHAM, William Edward | Amministratore | Wylam Dilly Gallowstree Common RG4 9BX Reading Berkshire | British | 65535180001 | ||||||
| BOLT, Thomas Allen | Amministratore | Flat 7 7 Egerton Place SW3 2EF London | England | American | 50947560004 | |||||
| BROWN, David Arthur | Amministratore | 15 Tuckers Town Road St. George's Waters Edge Hs 02 Bermuda | Bermuda | British | 129491310001 | |||||
| BYRNE, Mark James | Amministratore | 6 Long Lane HS02 Tuckers Town Roughill Bermuda | Bermuda | Irish | 136712110001 | |||||
| CACKETT, John Ronald | Amministratore | 15 South Road ME13 7LR Faversham Kent | British | 15346840001 | ||||||
| CARTWRIGHT, James Alexander Haggerston Gadsden | Amministratore | 33 St Mary Axe EC3A 8AA London Exchequer Court England | England | British | 245125430001 | |||||
| CHEETHAM, Howard James | Amministratore | Little Beeches Cobham Way, East Horsley KT24 5BH Leatherhead Surrey | England | British | 82408420001 | |||||
| CHUBB, Paul Alan | Amministratore | 58 Elmwood Drive KT17 2NN Ewell Surrey | England | British | 78587560001 | |||||
| COLEMAN, Barry | Amministratore | Batchelors Barns Green RH13 7QG Horsham West Sussex | British | 15199730001 | ||||||
| CROSS, Lynsey Jane | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | British | 168589940001 | |||||
| D'ARCY, Anthony Richard Hugh | Amministratore | Bourne House 10 Sandrock Hill Road GU10 4NS Farnham Surrey | United Kingdom | British | 60023430001 | |||||
| DZIADZIO, Richard Steven | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | Usa | American | 171618040001 | |||||
| EVANS, Philip George Holt | Amministratore | Marley Edge GU27 3PU Haselmere Surrey | British | 28731140001 | ||||||
| GRIEVES, Karl Geoffrey | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | United Kingdom | British | 114263470003 | |||||
| HALLMAN, Cynthia Louise | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | Canada | Canadian | 159156960001 | |||||
| HAMILTON, Janice Marie | Amministratore | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London 4th Floor England | England | American | 182129350001 | |||||
| HART, Trevor Frank | Amministratore | 10 Beech Avenue WD7 7DE Radlett Hertfordshire | British | 28731150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anv Holdings (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Minster Court Mincing Lane, 4th Floor EC3R 7AA London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ANV SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 29 lug 1997 Consegnato il 31 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The performance of the company's obligations due to the chargee under the terms of an underlease dated 29TH july 1997 and/or this rent deposit deed | |
Brevi particolari The rent deposit being £89,397.00 and interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed relating to rent deposit | Creato il 22 lug 1997 Consegnato il 07 ago 1997 | In corso | Importo garantito The rent reserved by and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the lease made 22ND july 1997 | |
Brevi particolari The deposit account in the sole name of the company at national westminster bank PLC holborn circus branch and the deposit sum being the sum of £26,500. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0