WOOL PROCESSORS LIMITED

WOOL PROCESSORS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOOL PROCESSORS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00752537
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOOL PROCESSORS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    2 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Barbara Modiano come amministratore in data 05 set 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 30 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 set 2015

    Stato del capitale al 21 set 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 007525370033, creata il 14 lug 2015

    34 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2014

    Stato del capitale al 22 set 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Barbara Modiano il 22 set 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 set 2013

    Stato del capitale al 26 set 2013

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Cessazione della carica di Giuseppe Modiano come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARSONS, Russell Thomas
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Segretario
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    170919930001
    MODIANO, Michael
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Amministratore
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    United KingdomItalian102968310001
    PARSONS, Russell Thomas
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Amministratore
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    EnglandBritish75173990005
    AARVOLD, John Merriman
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    Segretario
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    British19645650001
    AARVOLD, John Merriman
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Thanington Chichester Road
    RH4 1LR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish19645650001
    BENTLEY, Robert Alexander
    7a Prod Lane
    Baildon
    BD17 5BN Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    7a Prod Lane
    Baildon
    BD17 5BN Shipley
    West Yorkshire
    EnglandBritish12692920001
    DALLAS, John Eastwood
    28 Lennox Gardens
    SW1X 0DQ London
    Amministratore
    28 Lennox Gardens
    SW1X 0DQ London
    United KingdomBritish10487030002
    LOWE, Peter James
    Rhiwisg
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YE Ruthin
    Clwyd
    Wales
    Amministratore
    Rhiwisg
    Llanbedr Dyffryn Clwyd
    LL15 1YE Ruthin
    Clwyd
    Wales
    British45586640001
    MODIANO, Barbara
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    Amministratore
    4th Floor Broad Street House
    55 Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    EnglandItalian16420950001
    MODIANO, Giuseppe
    7 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    Amministratore
    7 Mulberry Walk
    SW3 6DZ London
    United KingdomItalian16420940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WOOL PROCESSORS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    G Modiano Ltd
    Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    55
    England
    06 apr 2016
    Old Broad Street
    EC2M 1RX London
    55
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione00872284
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    WOOL PROCESSORS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 lug 2015
    Consegnato il 17 lug 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A group guarantee and floating charge
    Creato il 07 gen 2011
    Consegnato il 10 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all its assets. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A group guarantee and floating charge
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 23 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all assets being all the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company, whatsoever and wheresoever present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 23 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 14 giu 1999
    Consegnato il 25 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee and all monies and liabilities due or to become due from any other members of the group to the chargee except any monies or liabilities due owing or incurred by such other member of the group as guarantor for the company
    Brevi particolari
    By way of floating charge all its undertaking property rights claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag (Amsterdam Branch)
    Transazioni
    • 25 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal charge
    Creato il 29 set 1998
    Consegnato il 05 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattels mortgage dated 30 december 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over those items listed on the schedule attached to the 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental legal charge
    Creato il 02 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattles mortgage dated 30TH december 1996
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over those items lisited in the schedule attached to the form 395. floating charge over those items listed in the schedule attached to the form 395 if and insofar as the fixed charge shall for any reason be ineffective.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental legal charge
    Creato il 04 lug 1997
    Consegnato il 08 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a chattels mortgage dated 30TH december 1996
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over those items listed in the annexed schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 30 dic 1996
    Consegnato il 07 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 20TH september 1996,this mortgage and any supplemental charge
    Brevi particolari
    The chattels,plant,machinery specified in the schedule and the floating charge over the chattels referred therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Riggs Ap Bank Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 02 feb 1996
    Consegnato il 06 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All undertaking property and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banca Nazionale Del Lavoro
    Transazioni
    • 06 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 02 feb 1996
    Consegnato il 06 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking property rights claims and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Francaise Du Commerce Exterieur
    Transazioni
    • 06 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 05 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nedcor Bank Limited
    Transazioni
    • 05 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 05 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banco Central Hispanoamericano Sa
    Transazioni
    • 05 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 05 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co.Limited
    Transazioni
    • 05 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 25 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Ba
    Transazioni
    • 25 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 27 gen 1993
    Consegnato il 04 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M616C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank Mees & Hope N.V.
    Transazioni
    • 04 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement of release accession and supplemental charge
    Creato il 29 lug 1991
    Consegnato il 06 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the german security dated 17TH aug 1990 and this deed
    Brevi particolari
    The existing and future collateral of the company as charged by the german security.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group guarantee & floating charge
    Creato il 29 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • H. Albert De Bary & Co Nv
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 ago 1990
    Consegnato il 24 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this charge.
    Brevi particolari
    The company's ownership and interest in the stock of such wool and wollenmaterials (the "collateral") from time to time in the area of the bremer woll - kammerei and K.E.s frachtkontor gmbh (the "security area") (see 395 ref M172 a nd cont'd) sheets for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group guarantee & floating charge
    Creato il 02 mar 1990
    Consegnato il 13 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Swiss Bank Corporation
    Transazioni
    • 13 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation
    Creato il 18 gen 1990
    Consegnato il 30 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Thereby certify that a deed of variation dated 18 jan 1990 and created by wool processing limited for varying the terms of a group guarantee and floating charge dated 4 july 88
    Brevi particolari
    As detailed in group guarantee and floating charge dated 4TH july 1988.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 30 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 05 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M317 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 05 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 05 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M312 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Riggs A.P. Bank Limited
    Transazioni
    • 05 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 05 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M287 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 05 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M282 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Hongkong & Shanghai Banking Corporation
    Transazioni
    • 05 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Group guarantee and floating charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 05 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking, property, rights, claims and assets (including uncalled capital and goodwill) of the company whatsoever and wheresoever present and future ("assets") (see doc M277 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Citibank Na
    Transazioni
    • 05 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0