SHEARINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHEARINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00753110
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHEARINGS LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova SHEARINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ernst & Young Llp
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHEARINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WA SHEARINGS LIMITED13 mar 200613 mar 2006
    SHEARINGS LIMITED24 ott 198924 ott 1989
    SMITHS SHEARINGS LIMITED25 feb 198725 feb 1987
    SHEARINGS HOLIDAYS LIMITED17 dic 198417 dic 1984
    JACKSONS OF ALTRINCHAM LIMITED12 mar 196312 mar 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHEARINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SHEARINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    41 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    40 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    41 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    41 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    43 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Cessazione della carica di Christopher Brown come amministratore in data 22 lug 2020

    1 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    49 pagineAM10

    Cessazione della carica di Richard James Calvert come amministratore in data 29 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul David Smith come amministratore in data 17 lug 2020

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    20 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    90 pagineAM03

    Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 22 mag 2020

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom a C/O Ernst & Young Llp 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY in data 10 giu 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Gary Speakman come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul David Smith come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Vincent Flower come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    28 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SHEARINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director69494710002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Segretario
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Segretario
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Segretario
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    WATKINS, Simon Andrew
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    Segretario
    6 Errington Close
    Chadwell St Mary
    RM16 4TA Grays
    Essex
    British34048840001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Segretario
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BROWN, Christopher
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishOperations Director138681610001
    BURKE, Jane Bain
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51003380001
    CALVERT, Richard James
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    Amministratore
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    C/O Ernst & Young Llp
    EnglandBritishCeo163434180002
    CONNOR, Ruth Joanne
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    England
    EnglandBritishManaging Director154083710001
    CRICHTON-MILLER, Hugh Angus
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Woodspeen West Lambourn Road
    Woodspeen
    RG20 8BU Newbury
    Berkshire
    BritishDirector16687350001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    FREEMAN, Paul Stephen
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishAccountant52600500001
    HILTON, Peter
    20 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    20 Doeford Close
    Culcheth
    WA3 4DL Warrington
    Cheshire
    BritishOperations Manager51002110001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    BritishChief Accountant51000070001
    KING, James Hughie
    2 Lumbrook Close
    Coley
    HX3 7UD Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lumbrook Close
    Coley
    HX3 7UD Halifax
    West Yorkshire
    BritishTour Director51002070003
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director30276880001
    NORTH, Terence Henry
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    Amministratore
    1 Ambleside
    Kendal Avenue
    CM16 4PT Epping
    Essex
    BritishDirector33990450001
    OWERS, Brian Charles
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    Amministratore
    19 Wilmot Way
    GU15 1JA Camberley
    Surrey
    EnglandBritishDirector34009090001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishDirector104434750001
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34191470001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHEARINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione218550
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SHEARINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and set-off agreement
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Coach asset chattel mortgage
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 18 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Coach assets being make jonckheere mistral registration numbers 4WA, Y705 wt and Y706HWT for further details of chattels charged please refer to 395. all right, title, benefit and interest in and to all insurances, the benefit of all contracts and agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 11 apr 2005
    Consegnato il 13 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The equipment being jonckheere mistral coach, reg. No. Y701 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No.Y702 hwt; jonckheere mistral coach, reg. No. Y703 hwt. For details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 08 nov 2002
    Consegnato il 12 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and items listed below or any part thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 08 nov 2002
    Consegnato il 09 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Equipment as set out in schedule to form 395 headed by volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.423 Reg. No.MV02 uln chassis no.285 Body no.33689, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg. Date mar.02, Fleet no.424 Reg.no. MV02 ulo chassis no. 286 body no.33690, Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT reg.date mar 02, fleet no.425 Reg.no., MV02ULP chassis no.287 Body no.33691 And all policies of insurance in respect thereof and all options and rights therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ba/Ca Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 04 nov 2002
    Consegnato il 14 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 427; reg no MV02 uls; chassis no: 289; body no: 33693. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 428; reg no MV02 ult; chassis no: 292; body no: 33694. volvo B12M van hool alizee T9 C46FT; reg: mar 02; fleet no: 429; reg no MV02 ulu; chassis no: 293; body no: 33695. (for further goods charged refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 nov 2002
    Consegnato il 14 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns the goods described in the schedule attached to the form 395: volvo B12M reg no MV02 umj; volvo BM12M reg no MV02 umk; volvo B12M reg no MV02 uml and others as described, and the tyres (as described) together with the benefit of contracts for sale, acquisition or refurbishment of the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 nov 2002
    Consegnato il 12 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interchange bayton road bayton rd industrial est exhall t/n WK123054. Interchange mill lane normanton industrial est west yorkshire t/n's WYK529098, WYK546441 and WYK444848. Interchange barleycastle lane stretton warrington t/n CH395349. For details of further property charged please refer to form 395, fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    (I) f/hold property known as winifred garage and adjoining land/blds at winifred road and charles st,skewen neath; t/nos: wa 667364,wa 747246,wa 690438 (possessory t/no); (ii) f/hold land on east side of barleycastle lane,appleton; ch 395349; (iii) f/hold property known as land to the east side of mill lane,normanton; t/nos: wyk 444848,wyk 529098 and wyk 546441 plus 4 other properties listed; all proceeds of sale thereof;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equipment mortgage
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured documents (as defined)
    Brevi particolari
    The equipment as listed with all rights,title,benefit and interest and all insurances thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC, as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the secured parties (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 giu 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 17 feb 1982
    Consegnato il 25 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a deenture dted 31ST may 1968
    Brevi particolari
    All book debts and other debts present & future .
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHEARINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 mag 2020Inizio dell'amministrazione
    24 mag 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Praticante
    2 St Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0