ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00755613
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ATKINS CONSULTANTS LIMITED01 giu 200401 giu 2004
    WS ATKINS CONSULTANTS LIMITED12 apr 198912 apr 1989
    W.S.ATKINS & PARTNERS29 mar 196329 mar 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 18 apr 2024

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Ws Atkins Limited come persona con controllo significativo il 12 ott 2023

    2 paginePSC05

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed atkins consultants LIMITED\certificate issued on 12/10/23
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 ott 2023

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 ott 2023

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Notifica di Ws Atkins Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione di Parfab Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022

    1 paginePSC07

    Cessazione di Confab Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan James Cullens come amministratore in data 07 apr 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA

    Nomina di Joanne Jarman come amministratore in data 17 mag 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Anderson come amministratore in data 17 mag 2021

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW

    1 pagineAD04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCALLISTER, Louise Mary
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238795760001
    NOBELEN, Elliot Michael
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    238796420001
    COLE, Simon Glenister
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish146000480001
    JARMAN, Joanne
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish283434280001
    BAKER, Helen Alice
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British108742050002
    DAVID, Katie Charmian
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    31 Sandy Lane
    TN13 3TP Sevenoaks
    Kent
    British73696680003
    DAVIS, Philip Stephen James
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    Segretario
    Hartland
    Woodside Drive
    RG18 9QD Hermitage
    Berkshire
    British71932630003
    GERRARD, Ashley Louise
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218094750001
    HAMES, Victoria Elizabeth
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    Segretario
    Flat 5
    70 Elmbourne Road
    SW17 8JJ London
    British102613150001
    HAYLOCK, Colin Peter
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    Segretario
    Downside The Drive
    Belmont
    SM2 7DP Sutton
    Surrey
    British47687610001
    LINDSAY, Catherine Elizabeth
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    218252890001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    Segretario
    Bradlow
    Sandy Lane
    GU3 1HF Guildford
    Surrey
    British36957420004
    TOMALIN, Richard Howarth
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    Segretario
    22 Fort Road
    GU1 3TE Guildford
    Surrey
    British13199870002
    WEBSTER, Richard
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    British85595860003
    ANDERSON, Mark Stephen
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish122463830003
    ARCHER, Paul Edward
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    Amministratore
    15 Woodgavil
    SM7 1AA Banstead
    Surrey
    British43573300001
    BALFE, Philip Joseph
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    Amministratore
    White Lodge
    Rectory Drive
    GU6 7PX Ewhurst
    Surrey
    British29923830001
    BALL, Geoffrey Robert
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Dial Cottage
    Church Lane Sevenhampton
    GL54 5SW Cheltenham
    Gloucestershire
    British83110540001
    BARRETT, Richard John, Bsc, Ceng, Mice
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    Amministratore
    Meadows End
    Hilliers Lane
    BS25 5NA Churchill
    North Somerset
    EnglandBritish121534930001
    BARROW, Jill Helen
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    Amministratore
    Blackslade Manor
    Widecombe In The Moor
    TQ13 7TF Devon
    British82386630001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    BINNIE, Christopher Jon Anthony
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    Amministratore
    4 Reigate Hill Close
    RH2 9PG Reigate
    Surrey
    British14298460001
    BROWN, Peter Allan
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    Amministratore
    Warren Road
    GU1 2HG Guildford
    48
    Surrey
    British30520670001
    BROWNE, Maximilian George Burrowes
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    Amministratore
    Knockcree
    Mahee Island Comber N1
    BT23 6EP
    County Down
    British19130630001
    BROYD, Timothy William, Professor
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    2 Hillbury Gardens
    CR6 9TQ Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish58859990001
    BUSBY, Peter Leonard
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    Amministratore
    8 The Common
    Ealing
    W5 3TR London
    British44813100001
    CATTO, Ivor Douglas
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    Amministratore
    Highfields
    KT21 2NL Ashtead
    12
    Surrey
    United KingdomBritish87066030002
    CLARK, Piers Benedict, Dr
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    Amministratore
    61 Downs Wood
    KT18 5UJ Epsom Downs
    Surrey
    United KingdomBritish84765290001
    CLARKE, Keith Edward
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish93106530002
    CLEMENTS, David Russell
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    Amministratore
    Southernhay
    High Street
    TA17 8SE Hinton St George
    Somerset
    United KingdomBritish22250060002
    COLLINS, Rodney
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    The Bothy
    Forest Road
    KT24 5ER East Horsley
    Surrey
    British12906160001
    CORRIE, Robert Keith
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    7 Hawkwood Dell
    Great Bookham
    KT23 4JR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish35957190001
    CULLENS, Alan James
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Woodcote Grove
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish189297280001
    CUMING, James Anthony
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    Amministratore
    74 Chenies Mews
    WC1E 6HU London
    EnglandBritish19130650002
    CUTHBERT, Richard Harry
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    Amministratore
    Saxons
    Meath Green Lane
    RH6 8JA Horley
    Surrey
    United KingdomBritish43573230002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    14 dic 2022
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England & Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01885586
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione755561
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Ashley Road
    KT18 5BW Epsom
    Woodcote Grove
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione755581
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second fixed and floating debenture
    Creato il 27 feb 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 27 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment in respect of the shepherd contracts
    Creato il 20 mar 2002
    Consegnato il 28 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assignor with full title guarantee, as continuing security for the performance and payment of all the secured obligations, hereby assigns and agrees to assign to the assignee all of its right, title, benefit and interest whatsoever present and future in: (a) clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract; and (b) the guarantee insofar as it relates to the contractor's obligations under clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract.
    Persone aventi diritto
    • TS4I (Process Utilities 1) Limited
    Transazioni
    • 28 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Sharge charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited)
    Creato il 13 ago 1998
    Consegnato il 21 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America International Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 04 gen 1996
    Consegnato il 18 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from bridgend custodial services limited to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    All dividends paid or payable on the shares being:- 24,000 "a" shares and 1,000 "b" shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 05 mar 1992
    Consegnato il 10 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date and in respect of the deposit agreement.
    Brevi particolari
    All rights to the repayment of the deposit (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 10 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral mortgage
    Creato il 14 giu 1988
    Consegnato il 28 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from atkins properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Brevi particolari
    L/H property k/a premises on the third floor of the western wing of sir william atkins house, southern link road epsom, surrey together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Collateral mortgage
    Creato il 21 apr 1988
    Consegnato il 10 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86
    Brevi particolari
    All the l/h property k/a the western wing of sir william atkins house, southern link road, epsom together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and the full benefit of the covenants and guarantee on the part of the company contained in the lease dated 4/3/88.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    Collateral mortgage
    Creato il 30 gen 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all moneys due or to become due from scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of subsititution dated 13/7/86
    Brevi particolari
    All the l/h property demised to the company by the lease or underlease (please see form 395 for full details of property) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time therein.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    Collateral mortgage
    Creato il 13 giu 1986
    Consegnato il 19 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/86.
    Brevi particolari
    Land and buildings situate to the west of and having access to ashley road, epsom, surrey and continuing to chalk lane on the east and k/a woodcote grove, title no:- p 17436 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 25 apr 1985
    Consegnato il 02 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company.
    Transazioni
    • 02 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 07 ago 1963
    Consegnato il 13 ago 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property including uncalled capital. (See doc 6).
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank LTD.
    Transazioni
    • 13 ago 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0