ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00755613 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ATKINS CONSULTANTS LIMITED | 01 giu 2004 | 01 giu 2004 |
| WS ATKINS CONSULTANTS LIMITED | 12 apr 1989 | 12 apr 1989 |
| W.S.ATKINS & PARTNERS | 29 mar 1963 | 29 mar 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 apr 2024
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modifica dei dettagli di Ws Atkins Limited come persona con controllo significativo il 12 ott 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed atkins consultants LIMITED\certificate issued on 12/10/23 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Ws Atkins Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Parfab Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Confab Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan James Cullens come amministratore in data 07 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Joanne Jarman come amministratore in data 17 mag 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stephen Anderson come amministratore in data 17 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Woodcote Grove Ashley Road Epsom Surrey KT18 5BW | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCALLISTER, Louise Mary | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238795760001 | |||||||
| NOBELEN, Elliot Michael | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 238796420001 | |||||||
| COLE, Simon Glenister | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 146000480001 | |||||
| JARMAN, Joanne | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 283434280001 | |||||
| BAKER, Helen Alice | Segretario | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 108742050002 | ||||||
| DAVID, Katie Charmian | Segretario | 31 Sandy Lane TN13 3TP Sevenoaks Kent | British | 73696680003 | ||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Segretario | Hartland Woodside Drive RG18 9QD Hermitage Berkshire | British | 71932630003 | ||||||
| GERRARD, Ashley Louise | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218094750001 | |||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Segretario | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| HAYLOCK, Colin Peter | Segretario | Downside The Drive Belmont SM2 7DP Sutton Surrey | British | 47687610001 | ||||||
| LINDSAY, Catherine Elizabeth | Segretario | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | 218252890001 | |||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Segretario | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| TOMALIN, Richard Howarth | Segretario | 22 Fort Road GU1 3TE Guildford Surrey | British | 13199870002 | ||||||
| WEBSTER, Richard | Segretario | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | British | 85595860003 | ||||||
| ANDERSON, Mark Stephen | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 122463830003 | |||||
| ARCHER, Paul Edward | Amministratore | 15 Woodgavil SM7 1AA Banstead Surrey | British | 43573300001 | ||||||
| BALFE, Philip Joseph | Amministratore | White Lodge Rectory Drive GU6 7PX Ewhurst Surrey | British | 29923830001 | ||||||
| BALL, Geoffrey Robert | Amministratore | Dial Cottage Church Lane Sevenhampton GL54 5SW Cheltenham Gloucestershire | British | 83110540001 | ||||||
| BARRETT, Richard John, Bsc, Ceng, Mice | Amministratore | Meadows End Hilliers Lane BS25 5NA Churchill North Somerset | England | British | 121534930001 | |||||
| BARROW, Jill Helen | Amministratore | Blackslade Manor Widecombe In The Moor TQ13 7TF Devon | British | 82386630001 | ||||||
| BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor | Amministratore | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | British | 983300008 | ||||||
| BINNIE, Christopher Jon Anthony | Amministratore | 4 Reigate Hill Close RH2 9PG Reigate Surrey | British | 14298460001 | ||||||
| BROWN, Peter Allan | Amministratore | Warren Road GU1 2HG Guildford 48 Surrey | British | 30520670001 | ||||||
| BROWNE, Maximilian George Burrowes | Amministratore | Knockcree Mahee Island Comber N1 BT23 6EP County Down | British | 19130630001 | ||||||
| BROYD, Timothy William, Professor | Amministratore | 2 Hillbury Gardens CR6 9TQ Warlingham Surrey | England | British | 58859990001 | |||||
| BUSBY, Peter Leonard | Amministratore | 8 The Common Ealing W5 3TR London | British | 44813100001 | ||||||
| CATTO, Ivor Douglas | Amministratore | Highfields KT21 2NL Ashtead 12 Surrey | United Kingdom | British | 87066030002 | |||||
| CLARK, Piers Benedict, Dr | Amministratore | 61 Downs Wood KT18 5UJ Epsom Downs Surrey | United Kingdom | British | 84765290001 | |||||
| CLARKE, Keith Edward | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | England | British | 93106530002 | |||||
| CLEMENTS, David Russell | Amministratore | Southernhay High Street TA17 8SE Hinton St George Somerset | United Kingdom | British | 22250060002 | |||||
| COLLINS, Rodney | Amministratore | The Bothy Forest Road KT24 5ER East Horsley Surrey | British | 12906160001 | ||||||
| CORRIE, Robert Keith | Amministratore | 7 Hawkwood Dell Great Bookham KT23 4JR Leatherhead Surrey | England | British | 35957190001 | |||||
| CULLENS, Alan James | Amministratore | Woodcote Grove Ashley Road KT18 5BW Epsom Surrey | United Kingdom | British | 189297280001 | |||||
| CUMING, James Anthony | Amministratore | 74 Chenies Mews WC1E 6HU London | England | British | 19130650002 | |||||
| CUTHBERT, Richard Harry | Amministratore | Saxons Meath Green Lane RH6 8JA Horley Surrey | United Kingdom | British | 43573230002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkinsréalis (Ws) Limited | 14 dic 2022 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Confab Limited | 06 apr 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Parfab Limited | 06 apr 2016 | Ashley Road KT18 5BW Epsom Woodcote Grove Surrey United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ATKINSRÉALIS CONSULTANTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second fixed and floating debenture | Creato il 27 feb 2003 Consegnato il 11 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Brevi particolari The present real property, the future real property all other real property now belonging to it other than the excluded real property, book debts bank acounts investments with a floating charge over the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating security document | Creato il 18 dic 2002 Consegnato il 27 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys,indebtedness,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever | |
Brevi particolari Excluding (I) 650 aztec west business park,bristol; (ii) block b 4-6 wellbrook court CB3 ona,cambridge; (iii) 3RD floor longcross court 47 newport rd,CF24 oad,cardiff; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security assignment in respect of the shepherd contracts | Creato il 20 mar 2002 Consegnato il 28 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The assignor with full title guarantee, as continuing security for the performance and payment of all the secured obligations, hereby assigns and agrees to assign to the assignee all of its right, title, benefit and interest whatsoever present and future in: (a) clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract; and (b) the guarantee insofar as it relates to the contractor's obligations under clauses 5.3 and 16 of the energy centre purchase contract. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Sharge charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited) | Creato il 13 ago 1998 Consegnato il 21 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage of shares | Creato il 04 gen 1996 Consegnato il 18 gen 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from bridgend custodial services limited to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Brevi particolari All dividends paid or payable on the shares being:- 24,000 "a" shares and 1,000 "b" shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement | Creato il 05 mar 1992 Consegnato il 10 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a guarantee of even date and in respect of the deposit agreement. | |
Brevi particolari All rights to the repayment of the deposit (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral mortgage | Creato il 14 giu 1988 Consegnato il 28 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from atkins properties limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86 | |
Brevi particolari L/H property k/a premises on the third floor of the western wing of sir william atkins house, southern link road epsom, surrey together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral mortgage | Creato il 21 apr 1988 Consegnato il 10 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of substitution dated 13/6/86 | |
Brevi particolari All the l/h property k/a the western wing of sir william atkins house, southern link road, epsom together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery and the full benefit of the covenants and guarantee on the part of the company contained in the lease dated 4/3/88. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral mortgage | Creato il 30 gen 1987 Consegnato il 18 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all moneys due or to become due from scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/85 as amended by a deed of subsititution dated 13/7/86 | |
Brevi particolari All the l/h property demised to the company by the lease or underlease (please see form 395 for full details of property) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time therein. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral mortgage | Creato il 13 giu 1986 Consegnato il 19 giu 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the scarron limited to the chargee under a loan agreement dated 30/10/86. | |
Brevi particolari Land and buildings situate to the west of and having access to ashley road, epsom, surrey and continuing to chalk lane on the east and k/a woodcote grove, title no:- p 17436 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 25 apr 1985 Consegnato il 02 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts and other debts due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 07 ago 1963 Consegnato il 13 ago 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property including uncalled capital. (See doc 6). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0