FURNIVAL ESTATES LIMITED

FURNIVAL ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFURNIVAL ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00758082
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2013

    Stato del capitale al 02 set 2013

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2011

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ago 2010

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    15 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Chi sono gli amministratori di FURNIVAL ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Amministratore
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister-In-Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Amministratore
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    BritishDirector40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishEstates Director15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritishAccountant58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    FURNIVAL ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The leasehold land known as land ajoining eyre street, furnival street, matilda way and matilda street, sheffield. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creato il 03 ago 1999
    Consegnato il 16 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 dic 1992
    Consegnato il 06 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £87,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed
    Brevi particolari
    Together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon (for full details of charge see form 395 and contd sheet).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 06 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental charge deed
    Creato il 04 dic 1992
    Consegnato il 08 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all other monies from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Redvers house union street sheffield south yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 lug 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 nov 1990
    Consegnato il 29 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from evans of leeds PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Redvers marse furnival street sheffield t/n: ywe 60547 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 19 set 1978
    Consegnato il 20 set 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,240,000 and all other monies due or to become due from evans of leeds limited to the chargee under the terms of a deed dated 17-6-61.
    Brevi particolari
    Land and buildings situate in sheffield being furnival house, furnival gate, as comprised in a lease dated 15-11-65.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 20 set 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 1975
    Consegnato il 02 lug 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Redvers slouse, furnival street, sheffield. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coventry Bank LTD
    Transazioni
    • 02 lug 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Dep of title deed w/i
    Creato il 23 dic 1971
    Consegnato il 28 dic 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £650,000
    Brevi particolari
    Property at junction of union st and furnival gate, sheffield, known as redvers house.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 28 dic 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 17 giu 1971
    Consegnato il 28 giu 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,335,000 & all other monies due or to become due from evans of leeds LTD to the chargee any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Furnival house, furnival gate, sheffield comprised in a lease dated 15/11/65.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transazioni
    • 28 giu 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1970
    Consegnato il 08 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £800,000 due from lonsdale properties LTD to the chargers and for further securing £700,000 outstanding under 2 charges dated respectively 24/06/68 and 30/12/68 and due from the company millshaw property co. LTD and mulgate investments LTD to the chargee.
    Brevi particolari
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way and matilda st, sheffield known as furnival house.
    Persone aventi diritto
    • Old Broad Street Securiting LTD
    Transazioni
    • 08 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1968
    Consegnato il 09 gen 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £427,000 & further securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68, all due from the company and the three other companies referred to therein
    Brevi particolari
    Land containing 891 square yards at the junction of furnival st & union lane in the city of sheffield.
    Persone aventi diritto
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transazioni
    • 09 gen 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1968
    Consegnato il 09 gen 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £427,000 & furthe securing £345,000 secured by a charge dated 24/06/68. all due from the company and three other companies referred to therein.
    Brevi particolari
    Land adjoining eyre st, furnival st, matilda way, & matilda st, sheffield. 4833 square yards approx.
    Persone aventi diritto
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transazioni
    • 09 gen 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 giu 1968
    Consegnato il 28 giu 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £345,000 and all other monies due or to become due from the co, to the chargee on any{ account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining eyre street,furnival street matilda way and matilda street sheffield together with the buildings erected thereon. (See doc 20).
    Persone aventi diritto
    • Old Broad Street Securities LTD.
    Transazioni
    • 28 giu 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0