ANTHONY HEAGNEY LIMITED

ANTHONY HEAGNEY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANTHONY HEAGNEY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00758178
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    • Commercio al dettaglio in negozi non specializzati con prevalenza di alimentari, bevande o tabacco (47110) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 feb 2019

    9 pagineLIQ03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom a Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 mar 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 feb 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 01 feb 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem acc cancelled 22/01/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Tesco Services Limited come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tracey Clements come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert John Welch come amministratore in data 09 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Blair come amministratore in data 09 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Steven Blair come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonny Mcquarrie come amministratore in data 17 ott 2017

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 feb 2017

    3 pagineAA

    Nomina di Tesco Services Limited come amministratore in data 31 ago 2017

    2 pagineAP02

    Nomina di Mrs Tracey Clements come amministratore in data 31 ago 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Tracey Clements come amministratore in data 22 feb 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    British204754740001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    BURROWS, Patrick James
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Gardeners Cottage
    The Lordship
    SG10 6HN Much Hadham
    Hertfordshire
    British86778310001
    COWELL, Martin William
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    32 Beverston Road
    Perton
    WV6 7UG Wolverhampton
    West Midlands
    British1614020001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    HEAGNEY, John Francis Alexander
    Yonder Cottage
    Carlton In Cleveland
    TS9 7BB Middlesbrough
    Cleveland
    Segretario
    Yonder Cottage
    Carlton In Cleveland
    TS9 7BB Middlesbrough
    Cleveland
    British15883870001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    Segretario
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    STANHOPE, David Raymond
    Fordstone Farm Cottage
    Park Lane Presall
    FY6 0NW Poulton-Le-Fylde
    Lancashire
    Segretario
    Fordstone Farm Cottage
    Park Lane Presall
    FY6 0NW Poulton-Le-Fylde
    Lancashire
    British32235930003
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    ELLIS, Carol Anne
    21 Harlsey Crescent
    Hartburn
    TS18 5DE Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    21 Harlsey Crescent
    Hartburn
    TS18 5DE Stockton On Tees
    Cleveland
    British41655380001
    HEAGNEY, Edna Olive
    Tudor Croft Stokesley Road
    TS14 8DL Guisborough
    Cleveland
    Amministratore
    Tudor Croft Stokesley Road
    TS14 8DL Guisborough
    Cleveland
    British4897530001
    HEAGNEY, John Francis Alexander
    Yonder Cottage
    Carlton In Cleveland
    TS9 7BB Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    Yonder Cottage
    Carlton In Cleveland
    TS9 7BB Middlesbrough
    Cleveland
    British15883870001
    HEAGNEY, Michael Anthony
    Tudor Croft Stokesley Road
    TS14 8DL Guisborough
    Cleveland
    Amministratore
    Tudor Croft Stokesley Road
    TS14 8DL Guisborough
    Cleveland
    EnglandEnglish4897510001
    HEALD, Frank Iddon
    36 Moorland Road
    FY6 7EU Poulton Le Fylde
    Amministratore
    36 Moorland Road
    FY6 7EU Poulton Le Fylde
    British21817350003
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    EnglandBritish57637410003
    HINTON, Matthew Thomas
    43 Lindisfarne
    Eden Park Oakerside
    SR8 1NP Peterlee
    County Durham
    Amministratore
    43 Lindisfarne
    Eden Park Oakerside
    SR8 1NP Peterlee
    County Durham
    British41655410001
    HOLMES, Colin Peter
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    66 Tolmers Road
    EN6 4JY Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish86778500001
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LLOYD, Jonathan Mark
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish160028560001
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MOORE, Dean
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    Amministratore
    Bleak House
    Oaks Road
    LE67 5UP Whitwick
    Leicestershire
    British94541520001
    MURRELLS, Steven Geoffrey
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    Amministratore
    Willow Farm
    Further Street
    CO10 5LD Assington
    Suffolk
    British98194710001
    NEASHAM, Lynn
    14 Simonside Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 0PE Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    14 Simonside Grove
    Ingleby Barwick
    TS17 0PE Stockton On Tees
    Cleveland
    British54628240001
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish148079740001
    O'NEILL, William Patrick
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British106806380001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    STANHOPE, David Raymond
    Fordstone Farm Cottage
    Park Lane Presall
    FY6 0NW Poulton-Le-Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    Fordstone Farm Cottage
    Park Lane Presall
    FY6 0NW Poulton-Le-Fylde
    Lancashire
    British32235930003
    THRELFALL, Kevin Patrick
    Perton House Pattingham Road
    Perton
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Perton House Pattingham Road
    Perton
    WV6 7HD Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1614060001
    TURNER, David
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish109813430001
    TURNER, David Richmond
    Woodhouse Farm
    Wyke
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Salop
    Amministratore
    Woodhouse Farm
    Wyke
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Salop
    EnglandBritish13374870003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ANTHONY HEAGNEY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01746058
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ANTHONY HEAGNEY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 feb 2000
    Consegnato il 22 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 91 parliament road, middlesbrough, county of middlesbrough. As comprised in an assignment dated 13.1.1995.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 51 roman road, middlesbrough, county of middlesbrough. As comprised in an assignment dated 13.1.1995.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 23 wynyard road, hartlepool, county of hartlepool. As comprised in an assignment dated 13.1.1995.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 46 stokesley road, marton, middlesbrough, county of middlesbrough. As comprised in a lease dated 13.3.1997.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 19 high street, normanby, redcar and cleveland. As comprised in a lease dated 17.6.1981.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 7 allendale road, ormesby, middlesbrough, county of middlesbrough. As comprised in an assignment dated 13.1.1995.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 10 and 11 norfolk place, berwick hills, middlesbrough, county of middlesbrough. As comprised in an assignment dated 18.10.1984.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 14 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 19A high street, normanby, redcar and cleveland. As comprised in an assignment dated 22.1.1990.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 08 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45 birchington avenue grangetown tyne and wear.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 06 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 and 9 kings road north ormesby middlesborough.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 06 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee upon any account and in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    Units E3 E4 and E5 skippers lane industrial estate eston middlesborough.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 04 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 1 cleveland street, normanby, redcar and cleveland as comprised in a conveyance dated 02/03/1964.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1999
    Consegnato il 04 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or day and nite stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as land east side lambton street, normanby, redcar and cleveland t/no: CE70894.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 giu 1997
    Consegnato il 19 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 46 stokesley road marton middlesbrough.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 02 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £275,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    51 roman road linthorpe middlesbrough cleveland. 91 parliament road middlesbrough cleveland. 7 allandale road ormesby cleveland. 23 wynyard hartlepool cleveland.
    Persone aventi diritto
    • Healds (Day and Nite) Limited
    Transazioni
    • 02 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 23 wynyard road hartlepool cleveland and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 51 roman road linthorpe middlesborough cleveland and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 91 parliment road middlesborough cleveland and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 7 allendale road ormesby middlesborough cleveland t/n TES22093 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 11 mar 1992
    Consegnato il 17 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 feb 1988
    Consegnato il 26 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 7 and 9 kings road north ormesby middlesbrough and/or the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ott 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H proeprty k/a 46 stokesley road marton middlesbrough cleveland and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 ott 1984
    Consegnato il 25 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H units 10/11 norfolk place berwick hills middlesbrough in the county of cleveland title no ce 77045 and/or the proceeds or sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 gen 1984
    Consegnato il 27 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold, 115 high street great ayton, middlesbrough, cleveland and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ANTHONY HEAGNEY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2018Inizio della liquidazione
    16 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0