CINEWORLD EXHIBITION LIMITED

CINEWORLD EXHIBITION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCINEWORLD EXHIBITION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00758966
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Power Road Studios
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UGC EXHIBITION LIMITED16 nov 199916 nov 1999
    VC EXHIBITION LIMITED23 ago 199623 ago 1996
    MGM EXHIBITION LIMITED06 apr 199306 apr 1993
    CANNON EXHIBITION LIMITED08 feb 198908 feb 1989
    CANNON CINEMAS LIMITED15 ott 198515 ott 1985
    CANNON CLASSIC CINEMAS LIMITED16 giu 198216 giu 1982
    CLASSIC CINEMAS PROPERTIES LIMITED26 apr 196326 apr 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Matthew Neil Eyre come amministratore in data 08 ago 2016

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charlotte Abigail Brookmyre come amministratore in data 08 ago 2016

    2 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2016

    Stato del capitale al 22 feb 2016

    • Capitale: GBP 4,906
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 gen 2015

    6 pagineAA

    Nomina di Merav Keren come amministratore in data 23 giu 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Bowcock come amministratore in data 09 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2015

    Stato del capitale al 09 feb 2015

    • Capitale: GBP 4,906
    SH01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Varie

    Section 519 ca 2006
    3 pagineMISC

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Charlotte Abigail Buck il 27 ago 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 dic 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Miss Charlotte Abigail Buck come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Wiener come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2014

    Stato del capitale al 07 feb 2014

    • Capitale: GBP 4,906
    SH01

    Cessazione della carica di Tony Yoe come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Olswang Cosec Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * 114 Power Road Studios Power Road Chiswick London W4 5PY* in data 17 ott 2013

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Seventh Floor 90 High Holborn London WC1V 6XX* in data 16 ott 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di Fiona Elizabeth Smith come segretario

    3 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CINEWORLD EXHIBITION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Fiona Elizabeth
    Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road
    Segretario
    Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road
    British182083050001
    EYRE, Matthew Neil
    Power Road Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Cineworld Group Plc
    England
    Amministratore
    Power Road Studios
    114 Power Road Chiswick
    W4 5PY London
    Cineworld Group Plc
    England
    EnglandBritish213190620001
    KEREN, Merav
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    Amministratore
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    United KingdomIsraeli199412670001
    HEWETT, John Christopher
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    Railway End 44 The Grip
    Linton
    CB1 6NR Cambridge
    Cambridgeshire
    British1934250001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Segretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    SMITH, Bernard Arthur
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    Segretario
    12 North Holmes Close
    RH12 4HB Horsham
    West Sussex
    British1678790001
    TAYLOR, Margaret
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Segretario
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Irish46146250002
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Segretario
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Segretario
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Segretario
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04051235
    83864780002
    ABBOTT, Trevor Michael
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Blendons Highcotts Lane
    West Clandon
    GU4 7XA Guildford
    Surrey
    British35278820001
    AUGER, George Albert
    1 Wellington Place
    Church Lane
    EN10 7JB Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Wellington Place
    Church Lane
    EN10 7JB Broxbourne
    Hertfordshire
    British53897760002
    BOWCOCK, Philip
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritish166007090001
    BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    Amministratore
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    British39498750002
    BROOKMYRE, Charlotte Abigail
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    Amministratore
    114 Power Road
    W4 5PY Chiswick
    Power Road Studios
    London
    EnglandBritish160575040004
    BURKE, Simon Paul
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    Amministratore
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    United KingdomIrish30017870003
    CARSON, Thomas Patrick
    1718 Via La Paz
    Burbank
    FOREIGN California 91501
    Usa
    Amministratore
    1718 Via La Paz
    Burbank
    FOREIGN California 91501
    Usa
    American31954990001
    COHEN, Malcolm
    B D O Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Amministratore
    B D O Stoy Hayward
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    United KingdomBritish125776060001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Amministratore
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    DHADWAR, Sukhrajit Singh
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritish98926850002
    DOEREN, William Bernard
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    Amministratore
    25 Ennismore Mews
    SW7 1AB London
    American34151930001
    DURA, Jean-Marie
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    Amministratore
    99 Bis De La Croix Rousse
    69004 Lyon
    France
    French67133410001
    EVANS, Martin John
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    44 Heath Gardens
    TW1 4LZ Twickenham
    Middlesex
    British38925660001
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    JENKINS, Barry Charles
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    Amministratore
    Homelands
    Rock Hill
    BR6 7PP Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish97730910001
    JONES, Richard David
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomBritish45933780006
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Amministratore
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    British70496800002
    SOMMERS, Michael John
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Beth House
    Norrels Drive, East Horsley
    KT24 5DR Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish115290220001
    SUSSFIELD, Alain
    9 Boulevard Delessert
    Paris, 75016
    FOREIGN France
    Amministratore
    9 Boulevard Delessert
    Paris, 75016
    FOREIGN France
    French66976410001
    TAYLOR, Margaret
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Amministratore
    19 Rusthall Avenue
    W4 1BW London
    Irish46146250002
    VERRECCHIA, Guy
    21 Villa Madrid
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    Amministratore
    21 Villa Madrid
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    French66971470001
    WIENER, Stephen Mark
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United KingdomUnited States41603390004
    WRIGHT, David Simon
    The East House
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RQ Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The East House
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RQ Wallingford
    Oxfordshire
    British40965810001
    YOE, Tony Tsen Wei
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    Amministratore
    Power Road
    Chiswick
    W4 5PY London
    Power Road Studios
    United Kingdom
    United KingdomBritish140231730002

    CINEWORLD EXHIBITION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a debenture dated 1 december 2004
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of each obligor (as defined) to bankers trust company as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) or any of them under each or any of the financing documents (as defined)in each case together with all costs,charges and expenses incurred by any lender in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brevi particolari
    F/H property k/a the abc cinema new broadway ealing greater london t/n MX438267 and other f/h properties l/h land and premises k/a the mgm cinema arcadian centre hurst street birmingham and other l/h property please refer to form 395 for full details of charged property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 15 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined therein) to the lenders (as defined therein) (or any of them) on any account whatsoever under each or any of the finance documents (as defined therein) (the "secured liabilities") provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that if it were so included, the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 11 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companythe "Security Agent"
    Transazioni
    • 11 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release
    Creato il 01 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all moneys due & to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the credit lyonaise bank nederland nv under the terms of a supplemental security assignment of december 1986 and any other agreement or document as defined in the deeed
    Brevi particolari
    The benefit of the distribution agreement listed in exhibit 4 therto a copy of which is annexed hereto for fuller details see doc M30/21 may/ln.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonais Bank Nederland Nv
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Amendments no 1 to the credit agreement dated 19.12.85
    Creato il 19 dic 1985
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees as defined under the terms of the credit agreement dated 2.12.85 and/or any other agreement or document as defined in the deed
    Brevi particolari
    All accounts, drafts, letter agreements letters of credits, notes any present or future agreements see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Banks (Rider 1)See Doc for Full Details
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Amendment no 1 to the credit agreement
    Creato il 19 dic 1985
    Consegnato il 07 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the banks as defined under the terms of the credit agreement dated 2/12/85 and/or any other agreement or document as defined in the deed
    Brevi particolari
    All present and future obligations and indebtedness (see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Banks Set Out in Rider 1
    Transazioni
    • 07 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Credit agreement
    Creato il 02 dic 1985
    Consegnato il 11 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the agreement notes, and this deed
    Brevi particolari
    All present and future obligations and indebtedness for further details see doc M242.
    Persone aventi diritto
    • The Banks Set Out in Rider 1
    Transazioni
    • 11 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 16 set 1985
    Consegnato il 17 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 16/9/85
    Brevi particolari
    (See doc M240). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 17 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 set 1984
    Consegnato il 03 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises k/a the classic cinema george lane folkestone shepway district in the county of kent floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 03 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 set 1984
    Consegnato il 03 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the classic cinema king st., Ramsgate in the thanet district of the county of the kent title no k 455890 floating charge & assignment of goodwill. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 03 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 lug 1984
    Consegnato il 12 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The classic cinema & adjoining car park at queen street deal, kent & assignment of the goodwill & connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 20 gen 1984
    Consegnato il 26 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and bldgs on the western side of high street, cosham, portsmouth k/a the classic cinema, high street, cosham, portsmouth assignment of goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1984
    Consegnato il 20 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the columbia theatre 93 shaftesbury avenue london, W1.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1984
    Consegnato il 20 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the picturedrome cinema at the junction of canada grove & linden road, bognor regis, west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1984
    Consegnato il 20 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as focus 1 and focus 2 high street shopping centre, brentwood, essex title no ex 277688.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 13 set 1983
    Consegnato il 15 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Scala cinema, 25/29 market street, nottiingham floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 15 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    Standard security which was presented at the register of saisnes on the 24-6-82
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 13 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Classic cinema, 59 kirk road, wishaw.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 13 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Classi cinema nicolson street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Standard security which was presented at the register of sasines on the 24-6-82
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 13 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Classic cinema, 520 sauchiehall street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 17 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All those premises comprising a cinematograph theatre situate in parts of both levels of the basement and part of the ground floor of the development.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 17 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 17 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cinema premises situate at 65 the haymarket, london, SW1 containing three cinemas with ancillary offices (please doc M21 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 17 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 11 giu 1982
    Consegnato il 17 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill (as per schedule attached hereto please see doc M210).
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 17 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Deed of release & substitution
    Creato il 30 gen 1981
    Consegnato il 11 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal deed dated 7TH june, 1972
    Brevi particolari
    Classic cinemas 1 and 2 horse fair, banbury, oxfordshire title no on 19304.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 11 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0