CASANOVA CLUB LIMITED

CASANOVA CLUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASANOVA CLUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00759903
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASANOVA CLUB LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CASANOVA CLUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 8EW London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASANOVA CLUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOP OF THE WORLD LIMITED06 mag 196306 mag 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASANOVA CLUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CASANOVA CLUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 feb 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di London Clubs Limited come persona con controllo significativo il 01 feb 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di London Clubs Limited come persona con controllo significativo il 01 feb 2018

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Krishan Kaushal come segretario in data 01 nov 2017

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Daniel Cohen come segretario in data 04 apr 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2016

    Stato del capitale al 01 feb 2016

    • Capitale: GBP 37,500
    SH01

    Cessazione della carica di Gary William Loveman come amministratore in data 01 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roy Alfred Charles Ramm come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Brick Street London W1J 7HQ a 55 Baker Street London W1U 8EW in data 24 mar 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2015

    Stato del capitale al 03 feb 2015

    • Capitale: GBP 37,500
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alexis George Oswald il 29 dic 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Alexis George Oswald come amministratore in data 27 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael John Silberling come amministratore in data 27 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CASANOVA CLUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KAUSHAL, Krishan
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Segretario
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    240946710001
    OSWALD, Alexis George
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    United KingdomBritish192560850002
    ROTHWELL, Michael
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    Amministratore
    Vicentia Court Bridges Court Road
    SW11 3GY London
    Apartment 43,
    United KingdomBritish116799060007
    COHEN, Michael Daniel
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    Segretario
    10722 Gray Havens Court
    NV89135 Las Vegas
    Nevada 89135
    Usa
    American121989990001
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    TALBOT, Richard Ian
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    Segretario
    Oakwood House Woodlands Court
    Filton Road Hambrook
    BS16 1QG Bristol
    British15269400002
    ATWOOD, Charles Lafayette
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Amministratore
    One
    Hughes Centre Drive
    Las Vegas Nevada
    Nv89109
    Usa
    Us120659070001
    BRAHAM, Michael Derrick
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    Amministratore
    Mayfield Middle Way
    Kinston Gorse
    BN16 1RY East Preston
    West Sussex
    British8456390001
    BRAWLEY, James
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    Amministratore
    3 Sydcote Rosendale Road
    West Dulwich
    SE21 8LH London
    British33732450001
    BRUNS II, John Frederic
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Amministratore
    9e Thorney Court Palace Gate
    W8 5NJ London
    Usa124522430002
    FREED, Simon Raymond
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Rose Court Woodland Lane
    Chorleywood
    WD3 5LS Rickmansworth
    Hertfordshire
    British1961260001
    HARDY, George Barry Conyers
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 The Bourne
    Townsend Lane
    AL5 2PW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish38430002
    ISAACS, Philip Leonard
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    Amministratore
    16 Imperial Court
    NW8 7PT London
    British12545650001
    KINGSLEY, Max Myer
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    Amministratore
    13 Hocroft Road
    NW2 2BP London
    British24036130002
    LOVEMAN, Gary William
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    Amministratore
    5 Sabrina Farm Road
    MA02482 Wellesley
    Ma 02482
    Us
    UsaAmerican86449970002
    PANNETT, George John Robert
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Maytime
    9 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    British1961250001
    RAMM, Roy Alfred Charles
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    Amministratore
    10 Brick Street
    W1J 7HQ London
    United KingdomBritish112948830001
    SILBERLING, Michael John
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Close
    W1H 6BR London
    19
    United Kingdom
    United KingdomUsa130048270002
    TIMMINS, William
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    Amministratore
    Apartment 8
    2-4 Hyde Park Gate
    SW7 5EW London
    British64708660004
    DRIVEMADE LIMITED
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    Amministratore
    10 Brick Street
    W1Y 8HQ London
    30185160003

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASANOVA CLUB LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lci Plc
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleThe Companies Act Of 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CASANOVA CLUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 17 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement and overdraft letter both dated 24TH may 1994 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 17 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mezzanine mortgage debenture
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 24 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the mezzanine lenders (as defined) under or in connection with clause 2 of the deed
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transazioni
    • 24 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Junior/senior mortgage debenture
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 24 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the borrower (as defined) and each company (as defined) to the banks under clause 2 of the deed
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 24 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior mortgage debenture
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 24 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness,monies,obligations and liabilities now or hereafter due,owing or incurred by each borrower (as defined therein) and each company (as defined therein) to the beneficiaries (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the senior mortgage debenture dated 7.4.93.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 24 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lcm mortgage debenture
    Creato il 07 apr 1993
    Consegnato il 07 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all indebtedness monies obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by each company (as defined therein) to the lender (as defined therein) under or in connection with clause 2 of the lcm mortgage debenture dated 7TH april 1993
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • London Clubs Management Limited
    Transazioni
    • 07 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 15 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See form 395 ref M82. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Overdraft Bank Andthe Overdraft Guarantors
    Transazioni
    • 15 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental senior guarantee and debenture
    Creato il 30 mar 1992
    Consegnato il 07 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agreement dated 5TH may 1989 (as amended)
    Brevi particolari
    See form 395 ref M175. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee Thereunder and to the Banks and Overdraft Bank
    Transazioni
    • 07 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed & supplemental charge
    Creato il 18 ago 1989
    Consegnato il 08 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    (See form 395 ref M272 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mezzarine guarantee & debenture
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank as Agent and Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior guarantee & debenture
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trade for the Banks and the Overdraft Bank
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Junior senior guarantee & debenture
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 23 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks
    Transazioni
    • 23 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0