SUPREME PLASTICS

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPREME PLASTICS
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00762772
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPREME PLASTICS?

    • (7499) /

    Dove si trova SUPREME PLASTICS?

    Indirizzo della sede legale
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUPREME PLASTICS?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MINIGRIP (LONDON) LIMITED30 mag 196330 mag 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPREME PLASTICS?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPREME PLASTICS?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2011

    Stato del capitale al 10 mar 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2007

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2006

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di SUPREME PLASTICS?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01740543
    43122090005
    BARRETO MORLEY, Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146176740003
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    EDMONDS, Graham Robert
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    British65795000001
    FORD, John
    10 Wentworth Road
    EN5 4NT Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    10 Wentworth Road
    EN5 4NT Barnet
    Hertfordshire
    British60304710001
    GREWAL, Nirmal Singh
    416 Staines Road West
    Ashford Common
    TW15 1RZ Ashford
    Middlesex
    Segretario
    416 Staines Road West
    Ashford Common
    TW15 1RZ Ashford
    Middlesex
    British9445900001
    URQUHART, Graham Kenneth
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    Segretario
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    British6005660002
    GREWAL, Nirmal Singh
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    Amministratore
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    United KingdomBritish9445900002
    GREWAL, Nirmal Singh
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    Amministratore
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    United KingdomBritish9445900002
    GREWAL, Nirmal Singh
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    Amministratore
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    United KingdomBritish9445900002
    HALPERN, David
    12 Glendore House
    30 Clarges Street
    W1J 7EG London
    Amministratore
    12 Glendore House
    30 Clarges Street
    W1J 7EG London
    British87283190001
    KISSANE, Denis
    31 Orchard Road
    Seer Green
    HP9 2XU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Orchard Road
    Seer Green
    HP9 2XU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British40311720001
    ROEDER, Inge
    63 West Heath Road
    NW3 7TH London
    Amministratore
    63 West Heath Road
    NW3 7TH London
    British16355630001
    ROEDER, Ronald William Hans, Dr
    15 Wickliffe Avenue
    N3 3EL London
    Amministratore
    15 Wickliffe Avenue
    N3 3EL London
    United KingdomBritish77222210001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001

    SUPREME PLASTICS ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 03 giu 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the plant and machinery vehicles computers and other equipment listed in the schedule to the form 395 and all spare parts replacements modifications and addition for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture deed
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 02 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 25 mar 1996
    Consegnato il 02 apr 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 mar 1993
    Consegnato il 23 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details refer to doc M395). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0