THE HOMARK GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE HOMARK GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00763384 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE HOMARK GROUP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Ann's Wharf 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HOMARK ASSOCIATES LIMITED | 06 giu 1963 | 06 giu 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 15 ott 2013
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 31 lug 2010 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Adrian David Gray come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE HOMARK GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 94529700001 | ||||||||||
| GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 146072380001 | |||||||||
| JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | 134328700001 | |||||||||
| VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | 43215170003 | |||||||||
| BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Segretario | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| ELDRED, Alan Herbert | Segretario | 20 Broadway Gardens PE1 4DU Peterborough Cambridgeshire | British | 59561230001 | ||||||||||
| FENTON, Nicola Jane | Segretario | Flat 1 56 Rosslyn Hill NW3 1ND Hampstead London | British | 31440290005 | ||||||||||
| HAMPSON, Michael David | Segretario | 58 Chestnut Avenue KT10 8JF Esher Surrey | British | 12688630001 | ||||||||||
| SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
| WAYMAN, Graham Charles | Segretario | Rose Cottage Newtown, Witchampton BH21 5AU Wimborne Dorset | British | 150508280001 | ||||||||||
| WISEMAN, Julian Richard | Segretario | 37 Elms Avenue Lilliput BH14 8EE Poole Dorset | British | 30890980001 | ||||||||||
| BELL, Geoffrey Ian | Amministratore | 10 Cellars Farm Road BH6 4DL Bournemouth Dorset | British | 56616870001 | ||||||||||
| BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | 79449700002 | |||||||||
| COLDWELL, David John | Amministratore | Oakleys Farmhouse Maiden Street Weston SG4 7DQ Hitchin Hertfordshire | British | 48115910001 | ||||||||||
| COOK, Graham Frederick | Amministratore | Graythorn Pinley Claverdon CV35 8NA Warwick Warwickshire | British | 56166410001 | ||||||||||
| CORBETT, Robert William | Amministratore | 9 Jupiter Way Corfe Mullen BH21 3XG Wimborne Dorset | British | 30890970001 | ||||||||||
| CRABB, David | Amministratore | 47 Kings Road HP4 3BJ Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 24375840002 | |||||||||
| DAVIES, Ieuan | Amministratore | 38b Vicarage Road BH31 7DP Verwood Dorset | British | 38455660001 | ||||||||||
| DE ST PAER, Michael John | Amministratore | Highway Farm Great Staughton PE19 5BG St. Neots Cambridgeshire | British | 77760720002 | ||||||||||
| DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | 134081280001 | ||||||||||
| FAIRHURST, Russell | Amministratore | 137 Colworth Road Leytonstone E11 1JE London | British | 44556020001 | ||||||||||
| HARTLEY, Kim | Amministratore | 48 Lulworth Avenue Hamworthy BH15 4DJ Poole Dorset | British | 35511980001 | ||||||||||
| HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | 17023730002 | ||||||||||
| KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | 136570610001 | |||||||||
| LEE, Richard John | Amministratore | The Gables Ledbury Road, Eastnor HR8 1EL Ledbury Herefordshire | British | 79012830002 | ||||||||||
| SPENCER, Peter David | Amministratore | The White House Broome Lane Blakedown DY10 3LP Kidderminster Worcestershire | British | 78077650001 | ||||||||||
| STEWART, Terence Harry Fitzgibbon | Amministratore | 83 Canford Cliffs Road Branksome Park BH13 7AH Poole Dorset | British | 24375850002 | ||||||||||
| WISEMAN, Julian Richard | Amministratore | 37 Elms Avenue Lilliput BH14 8EE Poole Dorset | British | 30890980001 | ||||||||||
| BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310650003 | |||||||||||
| S & W BERISFORD LIMITED | Amministratore | The Place 175 High Holborn WC1V 7AA London | 75310610006 |
THE HOMARK GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental deposit deed | Creato il 02 feb 1993 Consegnato il 03 feb 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30.4.79 (as defined) | |
Brevi particolari Deposit of £22,500 with messrs laytons,st.bartholomews,lewins mead,bristol,BS1 2NH. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 ott 1992 Consegnato il 27 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company and homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 43A pottery road parkstone poole dorset BH14 8RB t/n dti 12864. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 19 ott 1992 Consegnato il 21 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 ott 1992 Consegnato il 21 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 29 apr 1983 Consegnato il 18 mag 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current | |
Brevi particolari 64/64 shares in zerlina ii together with her boats & appurtenances offical no 309988. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 24 apr 1983 Consegnato il 05 mag 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the north east side of pattery road poole dorset and/or the proceeds of sale thereof title no at 12864. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0