THE HOMARK GROUP LIMITED

THE HOMARK GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE HOMARK GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00763384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE HOMARK GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOMARK ASSOCIATES LIMITED06 giu 196306 giu 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Stato del capitale al 15 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 31 lug 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di THE HOMARK GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    ELDRED, Alan Herbert
    20 Broadway Gardens
    PE1 4DU Peterborough
    Cambridgeshire
    Segretario
    20 Broadway Gardens
    PE1 4DU Peterborough
    Cambridgeshire
    British59561230001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Segretario
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    British31440290005
    HAMPSON, Michael David
    58 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Segretario
    58 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British12688630001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    WAYMAN, Graham Charles
    Rose Cottage
    Newtown, Witchampton
    BH21 5AU Wimborne
    Dorset
    Segretario
    Rose Cottage
    Newtown, Witchampton
    BH21 5AU Wimborne
    Dorset
    British150508280001
    WISEMAN, Julian Richard
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Segretario
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British30890980001
    BELL, Geoffrey Ian
    10 Cellars Farm Road
    BH6 4DL Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    10 Cellars Farm Road
    BH6 4DL Bournemouth
    Dorset
    British56616870001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    COLDWELL, David John
    Oakleys Farmhouse Maiden Street
    Weston
    SG4 7DQ Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Oakleys Farmhouse Maiden Street
    Weston
    SG4 7DQ Hitchin
    Hertfordshire
    British48115910001
    COOK, Graham Frederick
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Graythorn Pinley
    Claverdon
    CV35 8NA Warwick
    Warwickshire
    British56166410001
    CORBETT, Robert William
    9 Jupiter Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XG Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    9 Jupiter Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XG Wimborne
    Dorset
    British30890970001
    CRABB, David
    47 Kings Road
    HP4 3BJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    47 Kings Road
    HP4 3BJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish24375840002
    DAVIES, Ieuan
    38b Vicarage Road
    BH31 7DP Verwood
    Dorset
    Amministratore
    38b Vicarage Road
    BH31 7DP Verwood
    Dorset
    British38455660001
    DE ST PAER, Michael John
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Highway Farm
    Great Staughton
    PE19 5BG St. Neots
    Cambridgeshire
    British77760720002
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FAIRHURST, Russell
    137 Colworth Road
    Leytonstone
    E11 1JE London
    Amministratore
    137 Colworth Road
    Leytonstone
    E11 1JE London
    British44556020001
    HARTLEY, Kim
    48 Lulworth Avenue
    Hamworthy
    BH15 4DJ Poole
    Dorset
    Amministratore
    48 Lulworth Avenue
    Hamworthy
    BH15 4DJ Poole
    Dorset
    British35511980001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Richard John
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    The Gables
    Ledbury Road, Eastnor
    HR8 1EL Ledbury
    Herefordshire
    British79012830002
    SPENCER, Peter David
    The White House
    Broome Lane Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    The White House
    Broome Lane Blakedown
    DY10 3LP Kidderminster
    Worcestershire
    British78077650001
    STEWART, Terence Harry Fitzgibbon
    83 Canford Cliffs Road
    Branksome Park
    BH13 7AH Poole
    Dorset
    Amministratore
    83 Canford Cliffs Road
    Branksome Park
    BH13 7AH Poole
    Dorset
    British24375850002
    WISEMAN, Julian Richard
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Amministratore
    37 Elms Avenue
    Lilliput
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British30890980001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    THE HOMARK GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 02 feb 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 30.4.79 (as defined)
    Brevi particolari
    Deposit of £22,500 with messrs laytons,st.bartholomews,lewins mead,bristol,BS1 2NH.
    Persone aventi diritto
    • Matrix (Data Processing) Limited
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 27 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 43A pottery road parkstone poole dorset BH14 8RB t/n dti 12864.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from homark holdings LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 21 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 29 apr 1983
    Consegnato il 18 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current
    Brevi particolari
    64/64 shares in zerlina ii together with her boats & appurtenances offical no 309988.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 24 apr 1983
    Consegnato il 05 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north east side of pattery road poole dorset and/or the proceeds of sale thereof title no at 12864. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0