LEOVIC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEOVIC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00765592
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEOVIC LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LEOVIC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Offices Of Bdo Llp
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEOVIC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BENOIST GROUP LIMITED27 lug 199027 lug 1990
    LUSTY GROUP LIMITED(THE)31 dic 198131 dic 1981
    JACKSON,BANCE & CO.LIMITED27 giu 196327 giu 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEOVIC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LEOVIC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 feb 2018

    11 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT a The Offices of Bdo Llp Two Snowhill Birmingham B4 6GA in data 01 mar 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 feb 2017

    LRESSP

    Bilancio redatto al 25 mar 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2015

    Stato del capitale al 24 nov 2015

    • Capitale: GBP 53,762
    SH01

    Bilancio redatto al 27 mar 2015

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Charles Wilson come amministratore in data 12 ott 2015

    1 pagineTM01

    Varie

    Sect 519
    2 pagineMISC

    Bilancio redatto al 28 mar 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2014

    Stato del capitale al 01 ott 2014

    • Capitale: GBP 53,762
    SH01

    Bilancio redatto al 29 mar 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2013

    Stato del capitale al 14 ott 2013

    • Capitale: GBP 53,762
    SH01

    Bilancio redatto al 30 mar 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    12 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 gen 2012 al 31 mar 2012

    3 pagineAA01

    Nomina di Charles Wilson come amministratore

    3 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Ian Levesconte come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LEOVIC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHILTON, Mark
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    Segretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    British154974070001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    United KingdomBritish48949090001
    FULLER, Lucille
    7 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    Segretario
    7 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    British6354580001
    MERRICK, Paul
    25 Brook Street
    Aston Clinton
    HP22 5ES Aylesbury
    Bucks
    Segretario
    25 Brook Street
    Aston Clinton
    HP22 5ES Aylesbury
    Bucks
    British50738120001
    SALE, Richard Stephen George
    117 Church Road
    Earley
    RG6 1HG Reading
    Berkshire
    Segretario
    117 Church Road
    Earley
    RG6 1HG Reading
    Berkshire
    British90491420001
    SALE, Richard Stephen George
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    Segretario
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    British90491420002
    BOSWELL, Alan Edwin
    101 Hilmanton
    Lower Earley
    RG6 4HJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    101 Hilmanton
    Lower Earley
    RG6 4HJ Reading
    Berkshire
    British6841500001
    HOFFELNER, Swintger Karl Heinz
    Hill House Middle Hill
    TW20 0JL Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    Hill House Middle Hill
    TW20 0JL Englefield Green
    Surrey
    Austrian11673250001
    LE VESCONTE, Angela Marie
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    British12785650001
    LE VESCONTE, Angela Marie
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    73 Copthorne Road
    Croxley Green
    WD3 4AH Rickmansworth
    Hertfordshire
    British12785650001
    LEVESCONTE, Ian John
    73 Copthorne Road
    WD3 4AH Croxley Green
    Herts
    Amministratore
    73 Copthorne Road
    WD3 4AH Croxley Green
    Herts
    British6841480001
    MERRICK, Paul
    25 Brook Street
    Aston Clinton
    HP22 5ES Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    25 Brook Street
    Aston Clinton
    HP22 5ES Aylesbury
    Bucks
    British50738120001
    SALE, Richard Stephen George
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    Amministratore
    41 Chatsworth Road
    TQ1 3BJ Torquay
    Devon
    United KingdomBritish90491420002
    WILSON, Charles
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish123998480001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LEOVIC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    England
    06 apr 2016
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00363411
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    LEOVIC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 17 lug 1997
    Consegnato il 25 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 8 little common stanmore middlesex together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 24 dic 1996
    Consegnato il 31 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33 sefton avenue mill hill london borough of barnet t/n: MX181049.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 giu 1995
    Consegnato il 11 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or food ingredients for industry limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 1995
    Consegnato il 01 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or ritter-courivaud limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 1990
    Consegnato il 24 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 24 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 feb 1990
    Consegnato il 15 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 15 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 gen 1987
    Consegnato il 20 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1982
    Consegnato il 01 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the victoria engineering works, 78/86 percy road london on borough of hammersmith & fulham title no. 40171.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 08 nov 1982
    Consegnato il 11 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 set 1982
    Consegnato il 07 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H "bowling green mills," craghill road, thackly,. Bradford, west yorkshire title no. Wyk 246448.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee debenture
    Creato il 14 gen 1982
    Consegnato il 25 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    See doc M84. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 set 1981
    Consegnato il 18 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or V. benoist LTD. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    See doc M84. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1981Registrazione di un'ipoteca

    LEOVIC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 feb 2017Inizio della liquidazione
    20 ott 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praticante
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0