RALTON CARE HOMES LTD.

RALTON CARE HOMES LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRALTON CARE HOMES LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00769585
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RALTON CARE HOMES LTD.?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova RALTON CARE HOMES LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    23 Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RALTON CARE HOMES LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RALTON CATERING CO LIMITED01 ago 196301 ago 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di RALTON CARE HOMES LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per RALTON CARE HOMES LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Vincent Square Victoria London SW1P 2PN a 23 Buckingham Gate London SW1E 6LB in data 05 mag 2017

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Strike off 17/02/2017
    RES13

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Cherian Padinjarethalakal Thomas come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Patricia Maureen Hodgkinson come amministratore in data 29 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Bhanu Choudhrie come amministratore in data 22 set 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Cherian Padinjarethalakal Thomas come amministratore in data 22 set 2015

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2015

    Stato del capitale al 27 lug 2015

    • Capitale: GBP 54,400
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2014

    Stato del capitale al 28 lug 2014

    • Capitale: GBP 54,400
    SH01

    Cessazione della carica di Bhanu Choudhrie come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 30 lug 2013

    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bhanu Choudhrie il 30 lug 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Patricia Hodgkinson il 02 lug 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Patricia Hodgkinson il 02 lug 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 27 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RALTON CARE HOMES LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PUDARUTH, Satyabhama
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    23
    England
    Segretario
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    23
    England
    Mauritian138580700001
    CHOUDHRIE, Bhanu
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    23
    England
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6LB London
    23
    England
    EnglandBritish97817430002
    HARDWICK, Betty Louise
    Ravenhill Terrace
    7 The Laurels
    WS15 1BE Rugeley
    Staffordshire
    Segretario
    Ravenhill Terrace
    7 The Laurels
    WS15 1BE Rugeley
    Staffordshire
    British17688520002
    SOBTI, Sian Elizabeth
    10 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3EN Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    10 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3EN Birmingham
    West Midlands
    British157621570001
    JD SECRETARIAT LIMITED
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1K 6TT London
    Segretario
    1 Lumley Street
    Mayfair
    W1K 6TT London
    59292030001
    CHOUDHRIE, Bhanu
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    Amministratore
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    EnglandBritish97817430002
    HARDWICK, Betty Louise
    Ravenhill Terrace
    7 The Laurels
    WS15 1BE Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    Ravenhill Terrace
    7 The Laurels
    WS15 1BE Rugeley
    Staffordshire
    British17688520002
    HARDWICK, Gary Charles
    53 Stafford Road
    Great Wyrley
    WS6 6BA Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    53 Stafford Road
    Great Wyrley
    WS6 6BA Walsall
    West Midlands
    British17688550001
    HARDWICK, Keith Leonard
    31 Canterbury Way
    WS12 5YR Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    31 Canterbury Way
    WS12 5YR Cannock
    Staffordshire
    British46906650002
    HARDWICK, Philip
    26 Kingfisher Drive
    Little Haywood
    ST18 0FH Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    26 Kingfisher Drive
    Little Haywood
    ST18 0FH Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish17688530002
    HODGKINSON, Patricia Maureen
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    Amministratore
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    EnglandBritish44669100002
    PETERS, Robert Wade
    2 Frances Drive
    Bloxwich
    WS3 3NH Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    2 Frances Drive
    Bloxwich
    WS3 3NH Walsall
    West Midlands
    British53687180001
    ROOBOTTOM, Carl Ashley, Dr
    7 Warren Park
    Woolwich
    PL6 7QR Plymouth
    Amministratore
    7 Warren Park
    Woolwich
    PL6 7QR Plymouth
    British53687370002
    SOBTI, Anil Kumar, Dr
    10 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3EN Birmingham
    Amministratore
    10 Chad Road
    Edgbaston
    B15 3EN Birmingham
    United KingdomBritish57597580004
    THOMAS, Cherian Padinjarethalakal
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    Amministratore
    Vincent Square
    Victoria
    SW1P 2PN London
    1
    United KingdomBritish134863110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RALTON CARE HOMES LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Falcon Lodge Limited
    Vincent Square
    C/O Ccag
    SW1P 2PN London
    1
    England
    27 lug 2016
    Vincent Square
    C/O Ccag
    SW1P 2PN London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Uk
    Numero di registrazione3165690
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RALTON CARE HOMES LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 lug 2004
    Consegnato il 17 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a new town service station stafford road grat wyrley walsall staffordshire t/n SF349282. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-kernel hotel and cafe stafford road newtown walsall staffordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 set 1993
    Consegnato il 24 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a kernel hotel and cafe, stafford road, newtown, nr. Walsall, west midlands by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 ago 1989
    Consegnato il 11 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The fully licensed premises k/a the kernel hotel at stafford road, newton near walsall, west midalnds together with fixtures, fittings & goodwill of the business & benefit of the licences relating thereto. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bass Mitchell & Butlers Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 19 ott 1984
    Consegnato il 20 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account current or stated for goods supplied or otherwise.
    Brevi particolari
    F/H the kernel hotel stafford road newtown nr walsall staffordshire together with the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bass Mitchells and Butlers LTD
    Transazioni
    • 20 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1982
    Consegnato il 20 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H kernal hotel and cafe stafford road new town nr walsall staffs together with all trade and other fixtures and the goodwill of the business, the benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1981
    Consegnato il 02 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000
    Brevi particolari
    Kernal hotel and cafe stafford road, norton, near wallsall, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Courage Brewing Limited
    Transazioni
    • 02 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 lug 1972
    Consegnato il 24 lug 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Kernel cafe, stafford road, newtown, walsall, staffordshire to the with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0