TREADFAST TYRES LIMITED
Panoramica
Nome della società | TREADFAST TYRES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00774524 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TREADFAST TYRES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TREADFAST TYRES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Micheldever Micheldever Station SO21 3AP Winchester Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TREADFAST TYRES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per TREADFAST TYRES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2018 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 dic 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 dic 2016 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 11 dic 2015 al 31 mar 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 11 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2015 al 11 dic 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 set 2015 al 31 mar 2015 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Frederick Harris come segretario in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Barbara Gail Bowden come amministratore in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kerry Clay come amministratore in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Martin Handley come amministratore in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Denise Anne Mccarron come amministratore in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael John Peter Mc Carron come amministratore in data 12 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jonathan Robert Cowles come segretario in data 12 dic 2014 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TREADFAST TYRES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWLES, Jonathan Robert | Segretario | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | British | 193974400001 | ||||||
COWLES, Jonathan Robert | Amministratore | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Chartered Accountant | 122658610002 | ||||
WILKES, Duncan Stewart | Amministratore | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Company Director | 75861610001 | ||||
FELLOWS, Robert Bruce | Segretario | 2 Elmstone Close DY1 3LZ Dudley West Midlands | British | Company Director | 16046570002 | |||||
HARRIS, Mark Frederick | Segretario | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | 160157340001 | |||||||
MCCARRON, Michael John Peter | Segretario | The Hyde Kinver DY7 6LS Stourbridge Hyde House West Midlands | British | Company Director | 138422430001 | |||||
BOWDEN, Barbara Gail | Amministratore | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddesley Corbett Worcs | England | British | Director | 161261040001 | ||||
BROWN, Francis William | Amministratore | Cranham House Shenstone DY10 4DL Kidderminster Worcestershire | United Kingdom | British | Director | 20746810001 | ||||
CLAY, Kerry | Amministratore | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | England | British | Company Director | 174538200001 | ||||
FELLOWS, Robert Bruce | Amministratore | 2 Elmstone Close DY1 3LZ Dudley West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 16046570002 | ||||
HANDLEY, John Martin | Amministratore | Cakebole DY10 4RF Chaddesley Corbett Mintz Cottage Worcestershire | England | British | Company Director | 75640920001 | ||||
HARRIS, Mark Frederick | Amministratore | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddesley Corbet Worcestershire | United Kingdom | British | Company Director | 94136100001 | ||||
HARRIS, Ronald Michael | Amministratore | Tagg Farm Kidderminster Road DY10 4RA Chaddersley Corbett Worcestershire | British | Director | 12896380002 | |||||
MC CARRON, Michael John Peter | Amministratore | Hyde House The Hyde Kinver DY7 6LS Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Director | 25345570002 | ||||
MC GREGOR, Charles Alexander | Amministratore | Kingmoor Grange Kingstown Road CA3 0AX Carlisle Cumbria | British | Director | 25345580001 | |||||
MCCARRON, Denise Anne | Amministratore | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Hampshire England | United Kingdom | British | Company Director | 174705270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TREADFAST TYRES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treadfast Cradley Ltd | 10 feb 2017 | Micheldever Station SO21 3AP Winchester Micheldever Tyre Services Ltd England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Graphite Capital Gp Llp | 06 apr 2016 | Berkeley Square W1J 6BQ London Berkeley Square House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Graphite Capital Management Llp | 06 apr 2016 | Berkeley Square W1J 6BQ London Berkeley Square House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TREADFAST TYRES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creato il 20 gen 1994 Consegnato il 24 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 06 set 1991 Consegnato il 17 set 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the draft agreement of even date | |
Brevi particolari By way of specific charge the fixed assets by way of floating security those assets charged by way of specific charge pursuant to the foregoing paragraph (see form 395). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 27 feb 1991 Consegnato il 06 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises on the south side of milton road weston super mare title no:- av 134367. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ott 1988 Consegnato il 01 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Stanwix garage, 54 scotland road, stanwix, carlisle cumbria. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ott 1988 Consegnato il 01 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & premises on the south side of march end road, wednesfield wolverhampton title no. Sf 46225. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ott 1988 Consegnato il 01 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H tudor garage, 262 & 264 milton road, weston super mare. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ott 1988 Consegnato il 01 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 52 scotland road, stanwix carlisle, cumbria. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ott 1988 Consegnato il 01 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land situate at kingmoor road, st. Ann's, carlisle cumbria. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security presented for registration in scotland 4/9/85. | Creato il 24 ago 1985 Consegnato il 12 set 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 8/10 scotts street, annan dumfriesshire bounded on the north by scotts street along which it extends 55 yards or thereby. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 01 ago 1985 Consegnato il 07 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Endurance works maynpold fields cradley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over all book debts | Creato il 09 dic 1983 Consegnato il 14 dic 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises known as audnam garage camp hill wordsley near stourbridge west midlands title no sf 44235. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises known as albert avenue weston-super-mare somerset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0