CONCORD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONCORD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00775443
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONCORD LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CONCORD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONCORD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONCORD PLC31 mar 199231 mar 1992
    HARRISON INDUSTRIES PLC17 giu 198617 giu 1986
    CAULRIDGE LIMITED30 set 196330 set 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONCORD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CONCORD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    26 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    44 pagineAM10

    Soddisfazione dell'onere 63 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 64 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 61 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 62 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 65 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 66 in pieno

    1 pagineMR04

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    78 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    14 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Cardiff House Cardiff Road Barry Vale of Glamorgan CF63 2AW a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 15 apr 2023

    2 pagineAD01

    Cessazione di Stephen Patrick Murphy come persona con controllo significativo il 30 mar 2023

    1 paginePSC07

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Stephen Patrick Murphy come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stratagem Group Limited come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Patrick Murphy come segretario in data 31 mar 2023

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020

    33 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2019

    32 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CONCORD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAGNALL, David Leonard
    2 Meadway
    Bramhall
    SK7 1LA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    2 Meadway
    Bramhall
    SK7 1LA Stockport
    Cheshire
    British16576270001
    BRINDLEY, Peter Henry
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    Segretario
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    British11552730001
    MURPHY, Stephen Patrick
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    Segretario
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    British23821590002
    SENIOR, Ronald George
    Stable Lodge Church Lane
    Pavenham
    MK43 7PU Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Stable Lodge Church Lane
    Pavenham
    MK43 7PU Bedford
    Bedfordshire
    British6893660001
    SWALLOW, Jake Brangwyn Sheridan
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    Segretario
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    British1483180001
    BAGNALL, David Leonard
    2 Meadway
    Bramhall
    SK7 1LA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Meadway
    Bramhall
    SK7 1LA Stockport
    Cheshire
    British16576270001
    BARNES, John Kenneth
    Mere Heyes House Rowley Bank Lane
    High Legh
    WA16 0QJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Mere Heyes House Rowley Bank Lane
    High Legh
    WA16 0QJ Knutsford
    Cheshire
    British2409400001
    BRINDLEY, Peter Henry
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    Amministratore
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    British11552730001
    BRINDLEY, Peter Henry
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    Amministratore
    1 Albany Close
    West Bergholt
    CO6 3LE Colchester
    Essex
    British11552730001
    CANARI, Jean Claude
    Enclos Du Chateau
    Senozan
    FOREIGN Lugny 71260
    France
    Amministratore
    Enclos Du Chateau
    Senozan
    FOREIGN Lugny 71260
    France
    French16586440001
    COYNE, Anthony Edward
    34 Shipton Close
    Great Sankey
    WA5 5XS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    34 Shipton Close
    Great Sankey
    WA5 5XS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish68413490001
    DAVIES, Tudor Griffith
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    WalesWelsh68085230001
    DE MARGARY, Bridget Joanna Maria Margaret
    33 Clapham Common
    Northside
    SW4 0RW London
    Amministratore
    33 Clapham Common
    Northside
    SW4 0RW London
    EnglandBritish1380360002
    DELF, Peter James
    Park View
    Winchmore Hill
    N21 1QX London
    16
    Amministratore
    Park View
    Winchmore Hill
    N21 1QX London
    16
    United KingdomBritish2616750001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36687570001
    HARRISON, Anthony Roger
    Gorsecot Booth Road
    WA14 4AU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Gorsecot Booth Road
    WA14 4AU Altrincham
    Cheshire
    British32662080001
    HARRISON, Kenneth Arthur
    156 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    156 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish69700001
    HODGSON, Kenneth Reid Theophilus
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British4467930001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    IRWIN, John David
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Seeleys Orchard 39 Penn Road
    HP9 2LN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59361420001
    KERRISON, Bernard Edward
    15 Meadowcroft
    CM24 8LD Stansted
    Essex
    Amministratore
    15 Meadowcroft
    CM24 8LD Stansted
    Essex
    British7387900001
    KING, Anthony Vivian
    27 Thoresby Road Bramcote Hills
    Beeston
    NG9 3EN Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    27 Thoresby Road Bramcote Hills
    Beeston
    NG9 3EN Nottingham
    Nottinghamshire
    British43307620001
    MURPHY, Stephen Patrick
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    Amministratore
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    WalesBritish23821590002
    MURPHY, Stephen Patrick
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    Amministratore
    58 Nant Talwg Way
    CF62 6LZ Barry
    South Glamorgan
    WalesBritish23821590002
    SWALLOW, Jake Brangwyn Sheridan
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    Brickhill House
    North Oakley
    RG26 5TT Tadley
    Hampshire
    EnglandBritish1483180001
    STRATAGEM GROUP LIMITED
    c/o Concord Limited
    Cardiff Road
    CF63 2AW Barry
    Cardiff House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    c/o Concord Limited
    Cardiff Road
    CF63 2AW Barry
    Cardiff House
    Vale Of Glamorgan
    Wales
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00172737
    86916610001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CONCORD LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Stephen Patrick Murphy
    Cardiff Road
    CF63 2AW Barry
    Cardiff House
    Vale Of Glamorgan
    03 mag 2016
    Cardiff Road
    CF63 2AW Barry
    Cardiff House
    Vale Of Glamorgan
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CONCORD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 29 nov 2011
    Consegnato il 14 dic 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the scheme on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h properties k/a land lying to the south of brookhill road pinxton t/n DY111120, land and a building lying to the south of wharf road pinxton at/n DY126888 and land and buildings on the north and south sides of foundry street whittington moor t/n DY155340 (for details of further properies charged please refer to form MG01) and all proceeds of all policies of insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bestrustees PLC as Trustee
    Transazioni
    • 14 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a kaba door systems limited, wharf road, wharf industrial estate, pinxton, nottinghamshire t/no. DY126888.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being bas castings limited brookhill road pinxton derbyshire t/no DY111120.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being hi quality steel castings limited pottery lane whittington moor chesterfield t/no DY155354.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being hi quality steel castings limited foundry street whittington moor chesterfield t/no DY155340.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 nov 2004
    Consegnato il 25 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital trade debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    15 chiswick avenue mildenhall suffolk.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 gen 1998
    Consegnato il 28 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 comet way eastwoodbury lane southend on sea essex T.n EX492791. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 ott 1996
    Consegnato il 10 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the west side of hayes street hayes kent t/n SGL580569 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 ott 1996
    Consegnato il 10 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land adjoining the south west side of 1 crofton road orpington kent t/n SGL584615 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of legal charge
    Creato il 31 ago 1995
    Consegnato il 14 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of waterworks road coalville leicestershire held as f/h t/n-LT224033.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 and 2 leonard place, westerham road, keston, kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 84 hayes street, hayes, bromley, kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 1 crofton road, orpington, kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 58/60 chislehurst road, orpington, kent and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 08 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from burton & deakin motor group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at chiselhurst road, orpington t/no: K158154.
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1994
    Consegnato il 04 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south of broadstone hall road south stockport manchester t/no GM10961.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 mar 1994
    Consegnato il 18 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h k/a land and buildings on the south side of hatherton lane bloxwich walsall west midlands t/n SF79242.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 09 gen 1992
    Consegnato il 16 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The subjects k/a forty glenburn road, east kilbride title no. LAN41123.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 08 gen 1992
    Consegnato il 16 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The subjects forming and k/a plot no.12,garrelll road, burnside industrial estate, kilsyth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 10 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee onany account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time standing to the credit of the companys account with the bank of whatever nature and in whatever currency and lien on all securities and any other property held by the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of bletchley road, stockport greater manchester t/n gm 109024.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on north west and south west of battersea road, stockport greater manchester t/n gm 293022.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1992
    Consegnato il 17 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 10 metro industrial centre, st. John's road, isleworth, hounslow t/n agl 460.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CONCORD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 mar 2023Inizio dell'amministrazione
    09 apr 2024Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Ross David Connock
    Pricewaterhousecoopers Llp 2 Glass Wharf
    BS2 0FR Bristol
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 2 Glass Wharf
    BS2 0FR Bristol

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0