TILIA HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TILIA HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00775505 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TILIA HOMES LIMITED?
- Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni
Dove si trova TILIA HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TILIA HOMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| KIER LIVING LIMITED | 01 lug 2014 | 01 lug 2014 |
| KIER HOMES LIMITED | 29 ott 2008 | 29 ott 2008 |
| KIER RESIDENTIAL LIMITED | 10 lug 1998 | 10 lug 1998 |
| TWIGDEN LIMITED | 05 apr 1988 | 05 apr 1988 |
| HILLSON AND TWIGDEN PLC | 30 set 1963 | 30 set 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TILIA HOMES LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per TILIA HOMES LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 24 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 07 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 24 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per TILIA HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Gary Martin Ennis come amministratore in data 06 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Thomas Severson come amministratore in data 19 dic 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 007755050059, creata il 09 dic 2025 | 10 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 007755050058, creata il 05 dic 2025 | 10 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 007755050057, creata il 17 ott 2025 | 10 pagine | MR01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025 | 74 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel Stewart Wilson come segretario in data 30 set 2025 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 30 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 007755050056, creata il 07 ago 2025 | 63 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Tungsten Building Blythe Valley Business Park, Solihull, West Midlands, B90 8AU, United Kingdom a Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park Solihull B90 8AU in data 14 lug 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Andrew Chapman come amministratore in data 31 mar 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024 | 72 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 007755050052 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Henry Sharp come amministratore in data 02 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Thomas Severson come amministratore in data 02 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Jonathan Mark Hiles come amministratore in data 02 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark John Dilley come amministratore in data 28 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Richard Hammond come amministratore in data 15 mag 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 007755050055, creata il 11 giu 2024 | 29 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Andrew Chapman come amministratore in data 01 mar 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2023 | 49 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TILIA HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNIS, Gary Martin | Amministratore | Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building England | England | Irish | 109962140002 | |||||||||
| GIBBS, Alexander Victor Bland | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | United Kingdom | British | 309863660001 | |||||||||
| HILES, James Jonathan Mark | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 291937510001 | |||||||||
| SHARP, Giles Henry | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||||||
| ARMITAGE, Matthew | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 193476010001 | |||||||||||
| BRAND, Duncan Valentine | Segretario | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | British | 16800690001 | ||||||||||
| GARNER, Laurence | Segretario | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||||||
| GREGORY, Robert William | Segretario | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | British | 109817750001 | ||||||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | British | 116752570006 | ||||||||||
| HIGGINS, Philip | Segretario | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | 262491990001 | |||||||||||
| MCCOLL, Mary Jean | Segretario | Keysoe Lodge Keysoe Row West MK44 2JF Keysoe Bedfordshire | British | 34757030001 | ||||||||||
| MELGES, Bethan | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199693170001 | |||||||||||
| PARKER, Anthony Charles | Segretario | 5 The Oaks 17 Hartland Road CM16 4PF Epping Essex | British | 114041160001 | ||||||||||
| TWIGDEN, Gavin Robert | Segretario | 21 Dulce Road DE19 4HW St Neots Cambs | British | 29329940001 | ||||||||||
| WILSON, Daniel Stewart | Segretario | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | 299160510001 | |||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
| ADAMS, Graham Noel | Amministratore | 56 Munsbrough Lane Greasbrough S61 4NT Rotherham | England | British | 256775810001 | |||||||||
| ADAMS, Paul | Amministratore | Glen House Northgate Pinchbeck PE11 3SE Spalding Lincolnshire | England | British | 35238230004 | |||||||||
| AITCHISON, Andrew William | Amministratore | 9 Finlayson Place FK5 4FX Larbert Stirlingshire | United Kingdom | British | 104820240002 | |||||||||
| ANDERSON, John Bruce | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 29878320002 | |||||||||
| BAKER, Graham David | Amministratore | The Old Stables Warren Farm Barns Warren Lane MK45 4AS Clophill Bedforshire | British | 48564410002 | ||||||||||
| BARKE, Timothy John, Mr. | Amministratore | The Paddock Chapel End PE28 5TJ Sawtry Cambridgeshire | England | British | 295385930001 | |||||||||
| BESSANT, Martin Robert | Amministratore | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 223708970001 | |||||||||
| BHARADWAJ, Ishan | Amministratore | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | United Kingdom | British | 288277280001 | |||||||||
| BRAND, Duncan Valentine | Amministratore | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 16800690001 | |||||||||
| BRIDGES, David Crawford | Amministratore | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | England | British | 94982860001 | |||||||||
| BROOMFIELD, Matthew | Amministratore | 11 Centenary Road Brampton PE28 4YQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 108705890001 | ||||||||||
| BROWNE, Daniel Harry Rate | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 154494390001 | |||||||||
| BROWNE, David | Amministratore | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | United Kingdom | American | 283925820001 | |||||||||
| BUSBY, Colin Ronald William | Amministratore | 34 Duloe Road PE19 8FQ St Neots Cambridgeshire | England | British | 109817700001 | |||||||||
| CHAPMAN, Philip Andrew | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | England | British | 183918150002 | |||||||||
| COKER, Michael John | Amministratore | St Peter's Square M2 3DE Manchester One United Kingdom | England | British | 193135780001 | |||||||||
| COOPER, Sarah Jayne | Amministratore | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 188395230001 | |||||||||
| CRABB, Ian | Amministratore | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 296391950001 | |||||||||
| CREMIN, Theresa Bernadette | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | 185269400001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TILIA HOMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Guy Hands | 28 mag 2021 | Floor 2, Trafalgar Court Les Banques GY1 4LY St. Peter Port Occorian Administration (Guernsey) Limited Guernsey | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Guernsey | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Kier Group Plc | 06 apr 2016 | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0