SECKLOE 183 LIMITED

SECKLOE 183 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSECKLOE 183 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00776237
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SECKLOE 183 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SECKLOE 183 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SECKLOE 183 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BART SPICES LIMITED07 mar 198807 mar 1988
    BART PRINTS LIMITED04 ott 196304 ott 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di SECKLOE 183 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per SECKLOE 183 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 29 ago 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Damien Mead come amministratore in data 01 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jörg Herden come amministratore in data 19 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    2 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Damien Mead come amministratore in data 08 nov 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Keith James Crossley come segretario in data 29 gen 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Keith James Crossley come amministratore in data 29 gen 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2015

    Stato del capitale al 28 ott 2015

    • Capitale: GBP 60,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2014

    Stato del capitale al 03 ott 2014

    • Capitale: GBP 60,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 007762370015

    31 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ott 2013

    Stato del capitale al 15 ott 2013

    • Capitale: GBP 60,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di SECKLOE 183 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLARD, David John
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Amministratore
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish109277440001
    HERDEN, Jörg
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    Amministratore
    Industriestrabe
    49201 Dissen
    25
    Germany
    GermanyGerman239484930001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Segretario
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    English4433650001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Segretario
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    169652300001
    MARTIN, Alan Renwick
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    British1776940001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Segretario
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    British95053190001
    THOMAS, Keith Leslie
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    Segretario
    62 Old Dover Road
    Capel Le Ferne
    CT18 7HW Folkestone
    Kent
    British16622820001
    WAINE, Deborah Lynne
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    Segretario
    560 Wells Road
    Whitchurch
    BS14 9BB Bristol
    British95095690001
    BARD, Stanley
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    Amministratore
    7 Crooked Usage
    N3 3HD London
    British8229370001
    BARTLAM, Andrew James
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    Amministratore
    25 St Oswalds Court
    St Oswalds Road
    BS6 7HX Bristol
    Avon
    British39431620001
    BARTLAM, Josephine
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Amministratore
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    English4433650001
    BARTLAM, Reginald Joseph
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    Amministratore
    Longwood House Clevedon Road
    Failand
    BS8 3TL Bristol
    British4433670001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Amministratore
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritish142394800001
    BRENNAN, John Edward
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48192180002
    CAMPION, David Bardsley
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Monarchy Hall Farm
    Utkinton
    CW6 0JZ Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish9623060001
    CROSSLEY, Keith James
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Amministratore
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish169651660001
    FORD, Peter Michael
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    Amministratore
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    EnglandBritish16613000001
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglish3661150002
    GARLAND, Roderick John
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Huntleigh Hadham Cross
    SG10 6AL Much Hadham
    Hertfordshire
    United KingdomEnglish3661150002
    JOYNER, Gene Austin
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    Amministratore
    Brook House
    Mill Lane Compton Martin
    BS40 6NA Bristol
    Bath And North Somerset
    United KingdomBritish95053150002
    MEAD, Damien
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Amministratore
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    EnglandBritish189835980001
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Amministratore
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    SHAW, Edward Clive Vernon
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    Amministratore
    The Old Barn
    4 Seavale Mews
    BS21 7QB Clevedon
    North Somerset
    British41937220002
    SHAW, Matthew
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Amministratore
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish163272250001
    STOTT, Keith John
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Whitecroft Church Lane
    SG8 0SE Abington Pigotts
    Cambridgeshire
    EnglandBritish180692390001
    TAPE, Julie
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    Amministratore
    C/O Barts Spices Limited
    York Road
    BS3 4AD Bedminster
    Bristol
    United KingdomBritish95053190001
    TAPE, Julie
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    Amministratore
    The Garden House
    Butcombe Court
    BS40 5TR Redhill
    North Somerset
    United KingdomBritish95053190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SECKLOE 183 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    06 apr 2016
    York Road
    Bedminster
    BS3 4AD Bristol
    Bart Ingredients
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04937130
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SECKLOE 183 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2014
    Consegnato il 09 apr 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2010
    Consegnato il 14 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2009
    Consegnato il 21 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 21 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 24 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 24 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Warehouse premises fronting mead street,york road and st lukes rd,bedminster,bristol; AV215197. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 24 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Warehouse premises fronting mead street and york road,bedminster,bristol; BL63264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of accession pursuant to a debenture dated 5TH october 2001
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 05 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by each obligor to the chargees under each or any of the senior finance documents and the mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.Atrading as Rabobank International London Branch, as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 05 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 mag 2000
    Consegnato il 12 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 12 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 10 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 01 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 mar 1993
    Consegnato il 01 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the south east side of york road bedminster bristol avon t/no.AV215197 and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 ago 1984
    Consegnato il 13 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1980
    Consegnato il 08 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at premises at mead st, york road & st lukes road bristol together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over agreement to lease
    Creato il 02 feb 1979
    Consegnato il 07 feb 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the right title & interest of the company in the property being leasehold land situate at & having frontage on to mead street. York road & st. Lukes road bristol by virtue of an agreement dated 1.1.79 made between the company & the city council of bristol.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 02 feb 1979
    Consegnato il 07 feb 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0