FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED

FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 00777425
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b&z - convert to i&ps
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 14/08/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2012

    Stato del capitale al 20 ago 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Oldale come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Hendry come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil James Walker il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr George Murray Tinning il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Buchan Hendry il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alison Close il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Caroline Jane Sellers il 31 lug 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 10 gen 2009

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 12 gen 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Segretario
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    British45801060004
    CLOSE, Alison
    11 Pennington Drive
    Newton-Le-Willows
    Nr Warrington
    Amministratore
    11 Pennington Drive
    Newton-Le-Willows
    Nr Warrington
    United KingdomBritish118977740001
    OLDALE, Andrew
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Amministratore
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Amministratore
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    STEVENSON, James David
    Flat 33
    100 Drayton Park
    N5 1NF London
    Segretario
    Flat 33
    100 Drayton Park
    N5 1NF London
    British76020470002
    WAGHORN, Joanne Terese
    121 High Street
    Wanstead
    E11 2RL London
    Segretario
    121 High Street
    Wanstead
    E11 2RL London
    British14043340001
    CARPENTER, Paul Kenneth Christopher
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    Amministratore
    Grasmere
    36 Chester Road
    SK12 1EU Poyton
    Cheshire
    British119893930001
    GOMERSALL, Richard
    9 Claremont Road
    Culcheth
    WA3 4NT Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    9 Claremont Road
    Culcheth
    WA3 4NT Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish84786020001
    HENDRY, David Buchan
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    Amministratore
    Cardney Estate
    Butterstone
    PH8 0EY By Dunkeld
    Over Cardney Farmhouse
    Perthshire
    ScotlandBritish128555100001
    HEWITT, Paul William
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Hough Hall
    Newcastle Road Hough
    CW2 5JG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish163759450001
    MACDONALD, Alexander Sutherland
    25 Auchinloch Road
    G66 5ES Glasgow
    Amministratore
    25 Auchinloch Road
    G66 5ES Glasgow
    ScotlandBritish43085270001
    MINTER, Bert William Stanley
    382 Wanstead Park Road
    Cranbrook
    IG1 3UA Ilford
    Essex
    Amministratore
    382 Wanstead Park Road
    Cranbrook
    IG1 3UA Ilford
    Essex
    British14043350001
    PERRIN, Nicholas John
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Westfield
    5 Hough Lane
    SK9 2LG Wilmslow
    Cheshire
    British80173660001
    RANKIN, Yvonne Rose
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    Amministratore
    The Maples
    Holmes Chapel Road
    WA16 9RD Over Peover
    Cheshire
    British107621540001
    SINCLAIR, Graham Francis
    47 Colchester Road
    Leyton
    E10 6HB London
    Amministratore
    47 Colchester Road
    Leyton
    E10 6HB London
    British14043370001
    THOMPSON, Christopher Howard Gould
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish38632440001
    TINNING, George Murray
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    Amministratore
    17 Briar Road
    Kirkintilloch
    G66 3SA Glasgow
    United KingdomBritish126913730001
    WAGHORN, Anthony Melvyn
    132 Empress Avenue
    Wanstead
    E12 5HW London
    Amministratore
    132 Empress Avenue
    Wanstead
    E12 5HW London
    British28778380001
    WAGHORN, Melvyn
    121 High Street
    Wanstead
    E11 2RL London
    Amministratore
    121 High Street
    Wanstead
    E11 2RL London
    British14043360001
    WALKER, Neil James
    224a Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3AA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    224a Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3AA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish126913860001
    WELLENS, David Hugh
    Axholme
    Woodbourne Road New Mills
    SK22 3JX High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    Axholme
    Woodbourne Road New Mills
    SK22 3JX High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish33860330002

    FRANCIS & C.WALTERS(FUNERAL DIRECTORS)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1991
    Consegnato il 31 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    441, roman road, london borough of tower hamlets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 1989
    Consegnato il 07 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 96 albany road camberwell london SE1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 feb 1989
    Consegnato il 07 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 441 roman road london E3.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 feb 1989
    Consegnato il 07 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 nov 1963
    Consegnato il 20 nov 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £14,000
    Brevi particolari
    Undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Deerfold Holdings LTD.
    Transazioni
    • 20 nov 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 31 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0