HAVELOCK EUROPA PLC

HAVELOCK EUROPA PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAVELOCK EUROPA PLC
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00782546
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAVELOCK EUROPA PLC?

    • Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi (31010) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HAVELOCK EUROPA PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAVELOCK EUROPA PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HAVELOCK EUROPA PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 lug 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per HAVELOCK EUROPA PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    25 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    21 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da I2 Mansfield Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park Mansfield Nottinghamshire NG18 5FB a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 26 set 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    31 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2017

    71 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Hakeem Oluwatosin Yesufu come amministratore in data 18 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Donald William Borland come amministratore in data 06 apr 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Bruce Middleton come segretario in data 06 apr 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Donald William Borland come segretario in data 06 apr 2018

    1 pagineTM02

    Iscrizione dell'ipoteca 007825460008, creata il 02 mar 2018

    25 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 007825460007, creata il 08 mar 2018

    7 pagineMR01

    Nomina di Mr Shaun Allen Ormrod come amministratore in data 27 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Alexander Ritchie come amministratore in data 26 set 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HAVELOCK EUROPA PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MIDDLETON, Bruce
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    245012540001
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritish132405720006
    GODDEN, Ian Adam
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United Arab EmiratesBritish223235130001
    ORMROD, Shaun Allen
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish238467880001
    SWEETMAN, Richard John
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    ScotlandBritish123777750001
    YESUFU, Hakeem Oluwatosin
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    CanadaNigerian247751120001
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Segretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    230319390001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    British65759080002
    GRAY, Alexander Duncan
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    British187835130001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Segretario
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    188761690001
    MACSPORRAN, Graham
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    Segretario
    Rydal 103 Old Greenock Road
    PA7 5BB Bishopton
    Renfrewshire
    British71376370001
    SMITH, Eric Macdonald
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    Segretario
    21 Buchanan Drive
    G61 2EW Glasgow
    British76035570001
    WEBSTER, John Strachan
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    7 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Lanarkshire
    British718070001
    ASLET, Peter Michael
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    Burnbrae Horsewood Road
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British73615130003
    BALFOUR, Hew Edward Ogilvy
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    Amministratore
    Vicars Bridge
    Blairingone
    FK14 7NT Dollar
    The Mains Of Arndean
    Clackmannanshire
    United KingdomBritish132405720001
    BELL, Simon Leonard Lawrance
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    Amministratore
    16 Coleherne Mews
    SW10 9EA London
    British31486540002
    BORLAND, Donald William
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish66010670002
    BUDDEN, John Michael
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    29 Six Hills Road
    Walton Le Wolds
    LE12 8JF Loughborough
    Leicestershire
    British22057580001
    BURGESS, Andrew Elliott
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    FranceBritish184199220001
    DERBYSHIRE, Michael Joseph Christian
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    The Hill
    Whitmore
    ST5 5HU Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish11458180003
    DILLON, Peter Marshall
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    EnglandBritish201559530001
    DUNCAN, Robert Alexander
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    Amministratore
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    British48510002
    FAIRWEATHER, James Henry Whitton
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    The Hoolets Yett
    Pencaitland
    EH34 5EY Tranent
    East Lothian
    United KingdomBritish693160001
    FINDLAY, Grant Mcdowall
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    114 Duchy Road
    HG1 2HB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish65759080002
    GODDEN, Ian Adam
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    Amministratore
    9 Drax Avenue
    SW20 0EG London
    United KingdomBritish35852610002
    GOURLAY, John Malcolm
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    Amministratore
    57 Dick Place
    EH9 2JA Edinburgh
    United KingdomBritish574590003
    HAMILL, Ronald Gordon
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Cavendish House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish116784830001
    HURCOMB, David Stuart
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    Amministratore
    Moss Way
    Hillend Industrial Estate
    KY11 9JS Dalgety Bay
    Havelock Europa Plc
    Fife
    United KingdomBritish34516340004
    JEMMETT-PAGE, Shonaid Christina Ross
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    Amministratore
    Adams Lane
    Northiam
    TN31 6JR Rye
    Spanyards Farm
    East Sussex
    United KingdomBritish133875880001
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    ScotlandIrish43853920002
    KENNEDY, William Michael Clifford
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    Amministratore
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    British295080001
    KERR, Alastair Gibson
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Mansfield
    Hamilton Court Hamilton Way Oakham Business Park
    NG18 5FB Mansfield
    I2
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish124295480001
    LESSELS, Norman
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Amministratore
    11 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    British681350002
    LONGWORTH, Edward Nicholas
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    23 Tennent Park
    Mid Calder
    EH53 0RF Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish22057570001
    LOWERY, Richard
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    93 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish4842970001

    HAVELOCK EUROPA PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 mar 2018
    Consegnato il 09 mar 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All and whole the subjects on the south side of mitchelston drive, kirkcaldy, registered in the land register of scotland under title number FFE93583.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 02 mar 2018
    Consegnato il 14 mar 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All property charged under clause 3.1 of the charge, including:. (1) by way of legal mortgage all estates or interests in the freehold and leasehold property described in the schedule to the charge, together with all present and future buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures), which are at any time on or attached to the property; and. (2) by way of fixed charge: (I) all estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to the company now or at any time after the date of the charge (other than any property charged in terms of (1) above) together with all buildings, and fixtures (including trade and tenant's fixtures) which are at any time on or attached to the property; (ii) all present and future interests of the company in or over land or the proceeds of sale of it and all present and future licences of the company to enter upon or use land; (iii) the benefit of all other agreements relating to land which the company is or may become party to or otherwise entitled; (iv) all patents, utility models, registered and unregistered trade and service marks, rights in passing off, copyright, registered and unregistered rights in designs and database rights in each case now or in the future held by the company (whether alone or jointly with others) anywhere in the world and including any extensions and renewals of, and any application for such rights; (v) the benefit of all agreements and licences now or in the future entered into or enjoyed by the company relating to the use or exploitation by or on behalf of the company in any part of the world of any such rights as are referred to in (iv) above but owned by others; (vi) all the company's rights now or in the future in relation to trade secrets, confidential information and know how in any part of the world.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Scottish Enterprise
    Transazioni
    • 14 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2010
    Consegnato il 07 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant charges with full title guarantee its interest in the deposit account with payment of the liabilities.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Group (Cws) Limited
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 08 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south side of bailey grove road eastwood parish t/n NT75472 nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of substitution
    Creato il 07 feb 1991
    Consegnato il 09 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £360,000 and further advances
    Brevi particolari
    Land at bailey grove road, eastwood nottinghamshire title no. Nt 75472.
    Persone aventi diritto
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transazioni
    • 09 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 25 apr 1988
    Consegnato il 28 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400,000 and further advances due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    37, marylebourne lane, london W1.
    Persone aventi diritto
    • London and Manchester (Commercial Mortgages) Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 dic 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 mag 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 21/1/86
    Creato il 21 gen 1986
    Consegnato il 07 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Block 1 barnsford road inchinnan industrial estate, inchinnan, renfrew PA4 9RE.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 07 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HAVELOCK EUROPA PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 lug 2021Fine dell'amministrazione
    03 lug 2018Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Graham Douglas Frost
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0