CALEDONIAN TRAVEL LIMITED
Panoramica
Nome della società | CALEDONIAN TRAVEL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00782581 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
- Altri trasporti passeggeri via terra (49390) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1 Bridgewater Place Water Lane LS11 5QR Leeds West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CALEDONIAN COMPUTER SERVICES LIMITED | 28 nov 1963 | 28 nov 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 12 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2021 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 22 mag 2020 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 15 giu 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 10 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Speakman come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul David Smith come amministratore in data 01 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vincent Flower come amministratore in data 01 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 39 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Speakman il 13 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Flower il 13 nov 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Shearings Group Limited come persona con controllo significativo il 13 nov 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per A G Secretarial Limited il 09 giu 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard James Calvert come amministratore in data 18 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a One St Peter's Square Manchester M2 3DE in data 20 feb 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Vincent Flower come amministratore in data 13 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALVERT, Richard James | Amministratore | Water Lane LS11 5QR Leeds 1 Bridgewater Place West Yorkshire | England | British | Ceo | 163434180002 | ||||||||
SMITH, Paul David | Amministratore | Waterside Drive Wigan Pier Business Park WN3 5AZ Wigan C/O Specialist Leisure Group, Waterside House United Kingdom | England | British | Accountant | 228581750001 | ||||||||
BELL, Richard William | Segretario | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley West Yorkshire | British | 1124760001 | ||||||||||
HINSLIFF, Robert | Segretario | 30 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | 51000070001 | ||||||||||
MEDDES, Kenneth Sydney | Segretario | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | British | Company Director | 11486330002 | |||||||||
THOMAS, Joan Valerie | Segretario | 3 Broom Road LS24 9LH Tadcaster North Yorkshire | British | 51418740001 | ||||||||||
TURNER, Jayne Marie | Segretario | 33 Dingleway Appleton WA4 3AB Warrington Cheshire | British | Accountant | 117561640001 | |||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
BARR, John Malcolm | Amministratore | Kirkby House Kirkby Overblow HG3 1HJ Harrogate North Yorkshire | British | Chairman | 33219550001 | |||||||||
BARR, Nicholas Stuart | Amministratore | Mouse Hall Galphay HG4 3NT Ripon North Yorkshire | British | Director | 53565740001 | |||||||||
BARR, Robert Adam | Amministratore | Crow House Farm Burton Leonard HG3 3SX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 28813320001 | ||||||||
BARR, Stuart Alan | Amministratore | The Royal Hunting Lodge Shipton YO6 1BD Beningborough York | British | Group Managing Director | 509420001 | |||||||||
BELL, Richard William | Amministratore | Hadleigh House 128a Skipton Road LS29 9BQ Ilkley West Yorkshire | England | British | Finance Director | 1124760001 | ||||||||
FARMER, John Francis | Amministratore | Beck House 10 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | British | Chief Executive | 39030930001 | |||||||||
FLOWER, Vincent | Amministratore | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 91542970002 | ||||||||
KING, William John | Amministratore | Wheelgate House Reedness DN14 8ER Goole North Humberside | England | British | Managing Director | 35518260001 | ||||||||
MALLALIIEU, Simon | Amministratore | Beech House 45 Parish Ghyll Drive LS29 9PR Ilkley West Yorkshire | British | Director | 46919850001 | |||||||||
MARTIN, Lock | Amministratore | 95 King Lane Moortown LS17 5AX Leeds West Yorkshire | British | Director General Manager | 76356230001 | |||||||||
MAXWELL, William | Amministratore | Snelsins House Snelsins Lane BD19 3UE Cleckheaton West Yorkshire | United Kingdom | British | Tours Director | 108831380001 | ||||||||
MEDDES, Kenneth Sydney | Amministratore | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | Managing Director | 11486330002 | ||||||||
NEWBOLD, David Robert | Amministratore | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 30276880001 | ||||||||
NORMAN, Bernard Robert | Amministratore | Brackley House Marholm Road Ufford PE9 3BL Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 65467300001 | ||||||||
O'CALLAGHAN, Joseph | Amministratore | 9 Mallard Walk DE3 0TF Derby Derbyshire | England | British | Director | 110216340001 | ||||||||
SINCLAIR, Gordon | Amministratore | 176 Meadowburn G64 3LQ Bishopbriggs Glasgow | British | Director | 56102440001 | |||||||||
SINCLAIR, Gordon | Amministratore | 176 Meadowburn G64 3LQ Bishopbriggs Glasgow | British | Director | 56102440001 | |||||||||
SLATCHER, David John | Amministratore | 3 Brindle Heights Water Street Brindle PR6 8YA Chorley Lancashire | British | Company Director | 104434750001 | |||||||||
SMALL, Brian Michael | Amministratore | Laithe Croft Totties Lane HD1 1UL Holmfirth West Yorkshire | British | Company Director | 45198750001 | |||||||||
SPEAKMAN, Gary | Amministratore | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House Lancashire United Kingdom | England | British | Finance Director | 56066860001 | ||||||||
SPETCH, Paul Anthony | Amministratore | Rivelin Common Lane Warthill YO19 5XL York | England | British | Financial Director | 51421190001 | ||||||||
TURBILL, Stephen | Amministratore | 57 Maxwell Avenue Bearsden G61 1NZ Glasgow | British | Director General Manager | 76356340001 | |||||||||
WORMWELL, Denis | Amministratore | Miry Lane WN3 4AG Wigan Victoria Mill Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 124681340001 | ||||||||
WORSNUP, Peter Jonathan | Amministratore | 12 Grantley Place Bradley HD2 1LZ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 95865490001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shearings Group Limited | 06 apr 2016 | Waterside Drive WN3 5AZ Wigan Waterside House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CALEDONIAN TRAVEL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and set-off agreement | Creato il 20 apr 2006 Consegnato il 05 mag 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 apr 2006 Consegnato il 05 mag 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mar 2005 Consegnato il 31 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mar 2005 Consegnato il 31 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 mar 2005 Consegnato il 30 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite cross guarantee and mortgage debenture | Creato il 02 ott 2001 Consegnato il 18 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 ago 1997 Consegnato il 30 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due or owing or incurred by the company (whether as principal or security) to the chargee or any of the investors (as that terms is defined in the charge) pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and mortgage debenture | Creato il 15 ago 1997 Consegnato il 19 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys, obligations and liabilities for the time being due, owing or incurred by any group company to the chargee under or in connection with the finance documents and/or on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of offset | Creato il 19 mar 1992 Consegnato il 30 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from barr & wallace arnold trust PLC and/or trust motors limited and/or robert sibbald travel agents limited | |
Brevi particolari The balances at credit of any accounts held by the governor and company opf the bank of scotland in the name of caledonian travel limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CALEDONIAN TRAVEL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0