CALEDONIAN TRAVEL LIMITED

CALEDONIAN TRAVEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCALEDONIAN TRAVEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00782581
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri via terra (49390) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CALEDONIAN COMPUTER SERVICES LIMITED28 nov 196328 nov 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 mag 2021

    10 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 22 mag 2020

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom a 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR in data 15 giu 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    10 pagineLIQ02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 22 mag 2020

    LRESEX

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Gary Speakman come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul David Smith come amministratore in data 01 ott 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Vincent Flower come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    39 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Speakman il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Flower il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Shearings Group Limited come persona con controllo significativo il 13 nov 2017

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per A G Secretarial Limited il 09 giu 2017

    1 pagineCH04

    Nomina di Mr Richard James Calvert come amministratore in data 18 apr 2017

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a One St Peter's Square Manchester M2 3DE in data 20 feb 2017

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Vincent Flower come amministratore in data 13 ott 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALVERT, Richard James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo163434180002
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    BELL, Richard William
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    British1124760001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    British51000070001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Segretario
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    BritishCompany Director11486330002
    THOMAS, Joan Valerie
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    Segretario
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    British51418740001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Segretario
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Segretario
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2598128
    90084920001
    BARR, John Malcolm
    Kirkby House
    Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kirkby House
    Kirkby Overblow
    HG3 1HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChairman33219550001
    BARR, Nicholas Stuart
    Mouse Hall
    Galphay
    HG4 3NT Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Mouse Hall
    Galphay
    HG4 3NT Ripon
    North Yorkshire
    BritishDirector53565740001
    BARR, Robert Adam
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director28813320001
    BARR, Stuart Alan
    The Royal Hunting Lodge
    Shipton
    YO6 1BD Beningborough
    York
    Amministratore
    The Royal Hunting Lodge
    Shipton
    YO6 1BD Beningborough
    York
    BritishGroup Managing Director509420001
    BELL, Richard William
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hadleigh House
    128a Skipton Road
    LS29 9BQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director1124760001
    FARMER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChief Executive39030930001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    KING, William John
    Wheelgate House
    Reedness
    DN14 8ER Goole
    North Humberside
    Amministratore
    Wheelgate House
    Reedness
    DN14 8ER Goole
    North Humberside
    EnglandBritishManaging Director35518260001
    MALLALIIEU, Simon
    Beech House
    45 Parish Ghyll Drive
    LS29 9PR Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Beech House
    45 Parish Ghyll Drive
    LS29 9PR Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector46919850001
    MARTIN, Lock
    95 King Lane
    Moortown
    LS17 5AX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    95 King Lane
    Moortown
    LS17 5AX Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector General Manager76356230001
    MAXWELL, William
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    United KingdomBritishTours Director108831380001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Amministratore
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritishManaging Director11486330002
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director30276880001
    NORMAN, Bernard Robert
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director65467300001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector110216340001
    SINCLAIR, Gordon
    176 Meadowburn
    G64 3LQ Bishopbriggs
    Glasgow
    Amministratore
    176 Meadowburn
    G64 3LQ Bishopbriggs
    Glasgow
    BritishDirector56102440001
    SINCLAIR, Gordon
    176 Meadowburn
    G64 3LQ Bishopbriggs
    Glasgow
    Amministratore
    176 Meadowburn
    G64 3LQ Bishopbriggs
    Glasgow
    BritishDirector56102440001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director104434750001
    SMALL, Brian Michael
    Laithe Croft
    Totties Lane
    HD1 1UL Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Laithe Croft
    Totties Lane
    HD1 1UL Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishCompany Director45198750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    SPETCH, Paul Anthony
    Rivelin Common Lane
    Warthill
    YO19 5XL York
    Amministratore
    Rivelin Common Lane
    Warthill
    YO19 5XL York
    EnglandBritishFinancial Director51421190001
    TURBILL, Stephen
    57 Maxwell Avenue
    Bearsden
    G61 1NZ Glasgow
    Amministratore
    57 Maxwell Avenue
    Bearsden
    G61 1NZ Glasgow
    BritishDirector General Manager76356340001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001
    WORSNUP, Peter Jonathan
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant95865490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CALEDONIAN TRAVEL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5272464
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CALEDONIAN TRAVEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and set-off agreement
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2006
    Consegnato il 05 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 31 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Creato il 02 ott 2001
    Consegnato il 18 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 30 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due or owing or incurred by the company (whether as principal or security) to the chargee or any of the investors (as that terms is defined in the charge) pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC(Or Such Other Person as May from Time to Time Be the Security Trustee for the Purposes of the Said Charge) for Itself and as Trustee for the Investors (as that Term is Defined Therein)
    Transazioni
    • 30 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 19 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities for the time being due, owing or incurred by any group company to the chargee under or in connection with the finance documents and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 19 mar 1992
    Consegnato il 30 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from barr & wallace arnold trust PLC and/or trust motors limited and/or robert sibbald travel agents limited
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company opf the bank of scotland in the name of caledonian travel limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CALEDONIAN TRAVEL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 mag 2020Inizio della liquidazione
    09 mag 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0