TELSCOMBE TAVERN LIMITED

TELSCOMBE TAVERN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELSCOMBE TAVERN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00785488
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOGFOR PROPERTIES LIMITED20 dic 196320 dic 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al22 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 gen 2018

    9 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU in data 13 set 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL in data 09 feb 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 gen 2017

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mar 2016

    Stato del capitale al 01 mar 2016

    • Capitale: GBP 23,100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daryl Antony Kelly come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lucy Jane Bell come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 21 dic 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henry Jones come segretario in data 04 dic 2015

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 24 ago 2016 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Patrick James Gallagher come amministratore in data 23 giu 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523660001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishCompany Director895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592740001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445600001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Segretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    BritishCompany Secretary80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021580001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Amministratore
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    BritishCompany Director36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Amministratore
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritishDirector111108910001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Accountant26369940001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishCompany Director895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishChartered Secretary895960001
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    BritishManaging Director47141160001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishCompany Director47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    BritishCompany Director81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Secretary63895470001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishSolicitor46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishSolicitor46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Amministratore
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwissManaging Director78412270001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TELSCOMBE TAVERN LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    01 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    TELSCOMBE TAVERN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 set 1984
    Consegnato il 19 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 all monies due or to become due from the company to the chargee including moneys due for goods sold and delivered.
    Brevi particolari
    F/H telscombe tavern (formerly windmill cafe) south coast road telscombe cliffs, peacehaven, east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Brewery Company Limited
    Transazioni
    • 19 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1982
    Consegnato il 21 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000
    Brevi particolari
    The telscombe tavern 405, south coast road, telscombe cliff east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Scottich & Newcastle Beweries Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 apr 1981
    Consegnato il 10 apr 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including monies due for goods sold & delivered.
    Brevi particolari
    The telscombe, 405, south coast road, telscombe cliffs, newhaven, east sussex. Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. Together with all fixture.
    Persone aventi diritto
    • Charinglon & Compnay Limited.
    Transazioni
    • 10 apr 1981Registrazione di un'ipoteca

    TELSCOMBE TAVERN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 gen 2017Inizio della liquidazione
    15 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0