TRANSTAR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRANSTAR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00785717 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRANSTAR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TRANSTAR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Tyne And Wear England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRANSTAR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRANSTAR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 24 lug 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Barry Wilson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Ejupi come amministratore in data 13 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ms Svetlana Vinokur come amministratore in data 13 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ian Hudson come amministratore in data 13 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Paul Turner come amministratore in data 13 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Paul Turner come segretario in data 13 ott 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Victor Products Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF a Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ in data 17 lug 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Paul Turner come amministratore in data 25 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Guy Hetherington come amministratore in data 10 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRANSTAR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJUPI, Michael | Amministratore | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 212491340001 | |||||
| HUDSON, Ian | Amministratore | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238992200001 | |||||
| VINOKUR, Svetlana | Amministratore | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | United States | American | 238990610001 | |||||
| CLAY, David Nicholas | Segretario | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CLAY, David Nicholas | Segretario | 37 Larkhill Lane Formby L37 1LT Liverpool Merseyside | British | 45215990001 | ||||||
| CRAIG, Charles Thomas | Segretario | 18 Manor House Road Jesmond NE2 2LU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699370001 | ||||||
| DIXON, John | Segretario | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| JORDAN, Margaret Elizabeth | Segretario | 63 Harington Green L37 1PN Formby Merseyside | British | 47125150001 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Segretario | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Segretario | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Segretario | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | British | 109249450003 | ||||||
| WARREN, John Emmerson | Segretario | 1 Gellesfield Chare Whickham NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne | British | 796200001 | ||||||
| ALLAN, Gerard | Amministratore | 2 Glastonbury Close Priors Green DL16 6XP Spennymoor Durham | British | 44566730001 | ||||||
| CONE, Harry Douglas | Amministratore | 5 The Orchard Hepscott NE61 6HT Morpeth Northumberland | British | 796210001 | ||||||
| DIXON, John | Amministratore | 6 Shawbrow Close Dalesford Green NE7 7GW Newcastle Upon Tyne | British | 64250670002 | ||||||
| GUILE, Peter Richard | Amministratore | 516 Durham Drive Frankfort Il 60423 Usa | British | 56096610002 | ||||||
| HANKINS, Michael Freeman | Amministratore | Flat 2 Guisnes Court Chapel Road Tolleshunt Darcy CM9 8TL Maldon Essex | British | 12578790001 | ||||||
| HEARNE, John Thomas | Amministratore | 16947 Pineview Drive Lockport Illinois 60441 Usa | Usa Citizen | 70629260001 | ||||||
| HETHERINGTON, Guy | Amministratore | New York Way New York Industrial Park NE27 0QF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 109820740003 | |||||
| JACKSON, Hugh Graham | Amministratore | 41 Eastern Way Ponteland NE20 9RD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8699390001 | ||||||
| JORDAN, Keith Stuart | Amministratore | 63 Harington Green Formby L37 1PN Liverpool Silverdale | England | British | 139201050001 | |||||
| MARSH, Anthony Richard | Amministratore | 197 Melton Road NG12 4BU Nottingham Nottinghamshire | Irish | 34189400002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Amministratore | 7 Mary Agnes Street South Gosforth NE3 3XB Newcastle Tyne & Wear | British | 38845730002 | ||||||
| NICHOLSON, Clive | Amministratore | Dene Holme Lucy Street NE21 5PU Blaydon Tyne & Wear | British | 38845730003 | ||||||
| PICKERING, James Gordon | Amministratore | Silverhill House 270a Ecclesall Road South S11 9PS Sheffield South Yorkshire | British | 37974600001 | ||||||
| TURNER, Stephen Paul | Amministratore | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Great Britain | British | 212939770001 | |||||
| WILSON, Barry | Amministratore | C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | Usa | British | 79691350003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TRANSTAR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Products Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Tyne Dock East Side Port Of Tyne NE33 5SQ South Shields Unit 3a Tyne And Wear England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TRANSTAR LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 16 mar 2017 | La società ha identificato una persona registrabile in relazione alla società, ma non sono stati confermati tutti i dati richiesti di tale persona. |
TRANSTAR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 27 feb 1994 Consegnato il 04 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement | |
Brevi particolari The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 feb 1994 Consegnato il 04 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge | |
Brevi particolari The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and collateral debenture | Creato il 27 feb 1994 Consegnato il 08 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 set 1964 Consegnato il 05 ott 1964 | In corso | Importo garantito All moneys due etc. | |
Brevi particolari Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0