TRANSTAR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRANSTAR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00785717
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRANSTAR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TRANSTAR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Tyne And Wear
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRANSTAR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TRANSTAR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Stato del capitale al 24 lug 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Barry Wilson come amministratore in data 15 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Ejupi come amministratore in data 13 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Svetlana Vinokur come amministratore in data 13 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ian Hudson come amministratore in data 13 ott 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Paul Turner come amministratore in data 13 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Paul Turner come segretario in data 13 ott 2017

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Notifica di Victor Products Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da New York Way New York Industrial Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE27 0QF a Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side Port of Tyne South Shields Tyne and Wear NE33 5SQ in data 17 lug 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen Paul Turner come amministratore in data 25 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy Hetherington come amministratore in data 10 mag 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 apr 2016

    Stato del capitale al 06 apr 2016

    • Capitale: GBP 40,400
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2015

    Stato del capitale al 24 mar 2015

    • Capitale: GBP 40,400
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TRANSTAR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EJUPI, Michael
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican212491340001
    HUDSON, Ian
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238992200001
    VINOKUR, Svetlana
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican238990610001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    CRAIG, Charles Thomas
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    18 Manor House Road
    Jesmond
    NE2 2LU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699370001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    JORDAN, Margaret Elizabeth
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    Segretario
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    British47125150001
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Segretario
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Segretario
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Segretario
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    British109249450003
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    ALLAN, Gerard
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    Amministratore
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    British44566730001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    GUILE, Peter Richard
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    Amministratore
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    British56096610002
    HANKINS, Michael Freeman
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    Amministratore
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    British12578790001
    HEARNE, John Thomas
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Amministratore
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Usa Citizen70629260001
    HETHERINGTON, Guy
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish109820740003
    JACKSON, Hugh Graham
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699390001
    JORDAN, Keith Stuart
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    Amministratore
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    EnglandBritish139201050001
    MARSH, Anthony Richard
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Irish34189400002
    NICHOLSON, Clive
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    Amministratore
    7 Mary Agnes Street
    South Gosforth
    NE3 3XB Newcastle
    Tyne & Wear
    British38845730002
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    PICKERING, James Gordon
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British37974600001
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Great BritainBritish212939770001
    WILSON, Barry
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    UsaBritish79691350003

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRANSTAR LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Victor Products Holdings Ltd
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    06 apr 2016
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione00241316
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per TRANSTAR LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    16 mar 2017La società ha identificato una persona registrabile in relazione alla società, ma non sono stati confermati tutti i dati richiesti di tale persona.

    TRANSTAR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 feb 1994
    Consegnato il 04 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum aggregate amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited to the chargee as defined in a facilities agreement
    Brevi particolari
    The l/h property k/as site numbers bt 98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123 and any other f/h or l/h property vested in the company on 26 february 1994 and fixed equitable charge all its right title and interest in any f/h or l/h property acquired at any time after 26 february 1994.by way of charge over all those other assets undertakings and rights of the company present and future.equitable assignment the benefit of all those rights and remedies specified in clause 3.3 of the debenture.floating charge the company's undertaking and all its property rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1994
    Consegnato il 04 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A term loan facility in the maximum principal amount of £4,000,000 and the revolving credit facility and working capital facility in the maximum principal amount of £2,000,000 due or to become due from tiposon limited under the terms of a facilities agreement and this charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn.t/no.TY69123.fixed charge all those rights benefits and interests set out in clause 3.2 of the legal charge.by way of assignment in equity the benefit of all those rights remedies and interests specified in clause 3.3 of the legal charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and collateral debenture
    Creato il 27 feb 1994
    Consegnato il 08 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tiposon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/as site numbers BT98/1 and 98/7 victoria road,west hebburn tyne and wear.t/no.TY69123. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Plcas Agent
    Transazioni
    • 08 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 set 1964
    Consegnato il 05 ott 1964
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    Undertaking and goodwill all property and assets rpesent and future including uncalled capital. Fixed plant and machinery (see doc 10).
    Persone aventi diritto
    • Martins Bank LTD
    Transazioni
    • 05 ott 1964Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0