MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED

MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00785740
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GIBSON BOOTH
    15 Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Millshaw Ring Road Beeston Leeds LS11 8EG a C/O Gibson Booth 15 Victoria Road Barnsley S70 2BB in data 23 dic 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 dic 2016

    LRESSP

    Cessazione della carica di Ailish Martina Christian-West come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Matthew Syers come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert James Jewell come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roderick Michael Evans come amministratore in data 04 nov 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2016 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 45 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 39 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 44 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 41 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 43 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 40 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 46 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 42 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 47 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 48 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    4 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 mar 2016

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium a/c be extinquished 29/03/2016
    RES13

    Chi sono gli amministratori di MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARSHALL, Robert
    c/o Gibson Booth
    Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    15
    Segretario
    c/o Gibson Booth
    Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    15
    165899670001
    DON-WAUCHOPE, Despina
    c/o Gibson Booth
    Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    15
    Amministratore
    c/o Gibson Booth
    Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    15
    United KingdomBritish172870040001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    Amministratore
    Chapman House
    Chapman Square
    HG1 2SQ Harrogate
    Flat 9
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CHRISTIAN-WEST, Ailish Martina
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    EnglandIrish139461680004
    CLEARY, Peter James
    19 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Shenley Hill
    WD7 7AT Radlett
    Hertfordshire
    Irish75828760001
    COOPER, William Gerald
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    United KingdomBritish148434850001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    United KingdomBritish40175270005
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Amministratore
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HAMPSON, Lester Paul
    Wildshaw
    Hartfield Road
    TN8 7DZ Cowden
    East Sussex
    Amministratore
    Wildshaw
    Hartfield Road
    TN8 7DZ Cowden
    East Sussex
    United KingdomBritish110887160001
    HANNAH, Keith William Baillie
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    United KingdomBritish201091450001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    JENNINGS, Gerald Robert
    4 Castle Croft
    Long Lane Harden
    BD16 1BU Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Castle Croft
    Long Lane Harden
    BD16 1BU Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish60061140001
    JEWELL, Robert James
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    United KingdomBritish198635480001
    MARCUS, Ian
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    EnglandBritish85847920002
    MARTIN, Herbert William
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 2DS London
    64
    Amministratore
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 2DS London
    64
    United KingdomBritish131189890001
    PITT, James Oliver
    Manley Grove Ben Rhydding
    LS29 8QJ Ilkley
    7
    Amministratore
    Manley Grove Ben Rhydding
    LS29 8QJ Ilkley
    7
    EnglandBritish136529070001
    SYERS, Alan Matthew
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    Amministratore
    Millshaw Ring Road
    Beeston
    LS11 8EG Leeds
    EnglandBritish65588650002
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Amministratore
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Millshaw Investments Limited
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    06 apr 2016
    Ring Road
    LS11 8EG Leeds
    Millshaw
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione6006181
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    L S Millshaw Limited
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    England
    06 apr 2016
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione6123116
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 mar 2012
    Consegnato il 19 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re millshaw property co limited rent shortfall account and numbered 02154327 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 26 (formerly unit SU1A) millshaw park industrial park leeds t/nos WYK558045, WYK662724 and WYK595069. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 138 millshaw leeds t/no WYK325418. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 27 (formerly unit S1B) millshaw park industrial park leeds t/no WYK558044. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 140 millshaw leeds t/no WYK105748. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit SU3 millshaw park industrial estate leeds t/no WYK108303. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south side of millshaw park lane leeds t/nos WYK213415, WYK153874 and WYK255837. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 24 (formerly unit SU4) millshaw park trading estate leeds t/no wyk 111423. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 13 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 20 apr 2007
    Consegnato il 27 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south side of millshaw park lane leeds west yorkshire t/n WYK153874 all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery floating charge undertaking and all other property assets and rights.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Otherbeneficiaries
    Transazioni
    • 27 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 27 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings at unit SU3 millshaw park industrial estate leeds west yorkshire f/h t/n WYK108303 together with all buildings fixtures and fittings (excluding in the case of l/h property, landlords fixtures but including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery from time to time therein and the proceeds of sale of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 27 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 mar 2007
    Consegnato il 27 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings on the south side of millshaw park lane leeds west yorkshire f/h t/n WYK213415 together with all buildings fixtures and fittings (excluding in the case of l/h property, landlords fixtures but including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery from time to time therein and the proceeds of sale of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 27 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 apr 2006
    Consegnato il 12 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Units SU1A and SU1B millshaw industrial estate and land on the south east side of elland road t/n WYK558045 and WYK595069 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transazioni
    • 12 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 09 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a land at warehouse iii ring road beeston leeds t/n WYK488274 together with all buildings fixtures and fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and Thebeneficiaries (The Security Agent)
    Transazioni
    • 09 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 ott 2005
    Consegnato il 08 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the obligors or any of them to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a land at millshaw park avenue leeds t/n WYK255837. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 08 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/Hold land known as 33 rutland st,bradford,west yorkshire; WYK537837; all buildings and fixtures thereon; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 28 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold land known as holly hill park industrial estate, holly hill road, cinderford t/no. GR139243 and the leasehold land known as land on the south west side of kirkstall road, leeds (also known as burley court) t/no. WYK422283 and the freehold land known as land on the south side of regent street, blackburn, t/no. LA729804. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenture dated 27 may 1999
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings k/a units SU1A and SU1B millshaw park industrial estate millshaw leeds t/n WYK558045 and WYK558044. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and deposit
    Creato il 04 gen 2000
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evans of leeds PLC) and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds dated 7 april 1988, 1 february 1989, 29 march 1989, 4 december 1992, 23 december 1992, 4 november 1993, 29 september 1994, 17 november 1994, 12 july 1995, 26 september 1995, 20 september 1996, 14 march 1997, 16 july 1997, 18 september 1997, 25 june 1998, 30 october 1998, 30 april 1999, 4 june 1999, 28 june 1999, 30 june 1999, 6 august 1999, 1 october 1999, 7 october 1999, 14 october 1999, 5 november 1999 and 4 january 2000 all of which are supplemental to the trust deed dated 20 september 1985
    Brevi particolari
    £340,000.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 06 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly evan of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto (as defined)
    Brevi particolari
    Unit SU3 of millshaw park trading estate leeds west yorkshire t/n-WYK108303 together with all buildings and erections or fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creato il 03 ago 1999
    Consegnato il 16 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 giu 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release & substitution
    Creato il 18 set 1997
    Consegnato il 22 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20 september 1985 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Land at holly hill park ind est holly hill road cinderford t/n GR139243 together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 22 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 20 set 1996
    Consegnato il 24 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal amount of the original stock and the new stock together with interest arising under a trust deed dated 20TH september 1985,a deed of release and substitution dated 7TH april 1988,a first supplemental trust deed dated 1ST february 1989,a deed of release dated 29TH march 1989,a second supplemental trust deed dated 4TH december 1992,a third supplemental trust deed dated 4TH november 1993,a deed of release and substitution dated 29TH september 1994,a deed of confirmation dated 17TH november 1994,a deed of release dated 12TH july 1995,a deed of release and substitution dated 26TH september 1995 and a deed of release dated 21ST june 1996 together constituting and securing £100,000,000 11 per cent first mortgage debenture stock 2025.
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a land on the south side of regent street blackburn t/n LA729804.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 24 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 29 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £100,000,000 11 per cent. First mortage debenture stock 2025 and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and deeds to which it is supplemental as defined therein
    Brevi particolari
    Freehold land on the south east side of gelderd road,gildersome,leeds title number WYK374588 and freehold 28 castle street,shrewsbury title number SL53750. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MILLSHAW PROPERTY CO. LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 dic 2016Inizio della liquidazione
    02 nov 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Christopher Wetton
    Gibson Booth
    15 Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    South Yorkshire
    Praticante
    Gibson Booth
    15 Victoria Road
    S70 2BB Barnsley
    South Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0