MICRO-METALSMITHS LIMITED

MICRO-METALSMITHS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMICRO-METALSMITHS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00786649
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MICRO-METALSMITHS LIMITED?

    • fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (25110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MICRO-METALSMITHS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    ERNST & YOUNG LLP
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MICRO-METALSMITHS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per MICRO-METALSMITHS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2021

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2020

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2019

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2018

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2017

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 ott 2016

    18 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 ott 2015

    21 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 ott 2015

    18 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 apr 2015

    20 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    7 pagine2.16B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 nov 2014

    20 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    10 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    45 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kirkdale Road Kirkbymoorside York YO62 6PX* in data 21 mag 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013

    30 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2013

    Stato del capitale al 05 giu 2013

    • Capitale: GBP 81,606
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    34 pagineAA

    Nomina di Mr Mark David Chappell come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MICRO-METALSMITHS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, David
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritish231639300002
    CHAPPELL, Mark David
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritish138526110001
    GUNN, Gordon James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritish90601540005
    MCGREEVY, John Dominic
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    United KingdomBritish123019430003
    SHAW, Christopher William
    Starfitts House
    YO62 7JF Kirkbymoorside
    Amministratore
    Starfitts House
    YO62 7JF Kirkbymoorside
    United KingdomBritish928390001
    SHAW, William Benjamin
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritish90601530004
    BIRNIE, Paul Ernest
    Knowle Hill 83 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    Segretario
    Knowle Hill 83 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    English19476190001
    CUMING, Deborah Jane
    4 Franchise Terrace
    Middleton Road
    YO18 8AN Pickering
    North Yorkshire
    Segretario
    4 Franchise Terrace
    Middleton Road
    YO18 8AN Pickering
    North Yorkshire
    British88276360001
    GIBSON, William Mcaulay
    Kings Faun
    58 Kings Road
    LS29 9AT Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Kings Faun
    58 Kings Road
    LS29 9AT Ilkley
    West Yorkshire
    British61031430001
    SAFHILL, David George
    28 Holly Tree Lane
    Dunningyon
    YO1 5RD York
    North Yorkshire
    Segretario
    28 Holly Tree Lane
    Dunningyon
    YO1 5RD York
    North Yorkshire
    British33290730001
    SHAW, Christopher William
    Starfitts House
    YO62 7JF Kirkbymoorside
    Segretario
    Starfitts House
    YO62 7JF Kirkbymoorside
    British928390001
    BIRNIE, Paul Ernest
    Knowle Hill 83 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Knowle Hill 83 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    EnglandEnglish19476190001
    EDDISON, Ian Gregory, Dr
    12 The Paddocks
    Bugbrooke
    NN7 3QR Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    12 The Paddocks
    Bugbrooke
    NN7 3QR Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish56662220001
    GIBSON, William Mcaulay
    Kings Faun
    58 Kings Road
    LS29 9AT Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kings Faun
    58 Kings Road
    LS29 9AT Ilkley
    West Yorkshire
    British61031430001
    GREENER, Stephen Robert
    Manor Farm
    Ebberston
    YO13 9ND Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Ebberston
    YO13 9ND Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish29940050001
    MCGREEVY, John Dominic
    Kirkdale Road
    Kirkbymoorside
    YO62 6PX York
    Amministratore
    Kirkdale Road
    Kirkbymoorside
    YO62 6PX York
    United KingdomBritish123019430003
    PARKIN, Stephen David
    Heron Leas
    Lendales Lane
    YO18 8EE Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Heron Leas
    Lendales Lane
    YO18 8EE Pickering
    North Yorkshire
    EnglandBritish72612530001
    ROBINSON, Joseph Rawlings
    25 Greenbrier Drive
    FOREIGN Summit
    New Jersey
    Usa
    Amministratore
    25 Greenbrier Drive
    FOREIGN Summit
    New Jersey
    Usa
    United StatesAmerican89240600001
    SHAW, Barbara Joan
    Highfields
    Swainsea Lane
    YO18 8NF Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Highfields
    Swainsea Lane
    YO18 8NF Pickering
    North Yorkshire
    United KingdomBritish7767680003
    SHAW, Mary Jeannette Robinson
    Starfitts House Starfitts Lane
    Kirkbymoorside
    YO62 7JF York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Starfitts House Starfitts Lane
    Kirkbymoorside
    YO62 7JF York
    North Yorkshire
    United KingdomAmerican10687630001

    MICRO-METALSMITHS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 31 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a heathfield ings lane kirkmoorside north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 2006
    Consegnato il 31 ago 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h and l/h property known as land and buildings lying to the east side of west lund lane kirkbymoorside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 2005
    Consegnato il 01 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    £500,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Land and buildings at thornton road industrial estate pickering north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 set 2003
    Consegnato il 16 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as land lying to the east of west lund lane, kirkbymoorside t/no NYK90764; f/h property known as land and buildings on the east side of west lund lane, kirkbymoorside NYK242356.
    Persone aventi diritto
    • Mohawk Overseas Investments Limited
    Transazioni
    • 16 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 lug 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First fixed and floating charge
    Creato il 30 ago 1998
    Consegnato il 18 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all our book debts and other debts present and future as are not sold to and bought by the chargee under an agreement dated 30.08.98 and by way of floating charge on all proceeds of our book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 18 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 08 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Mrs. Mary Jeanette Robinson Shaw
    Transazioni
    • 08 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 giu 1988
    Consegnato il 18 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 nov 1985
    Consegnato il 19 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises off ings lane, kirkbymoorside, york, north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 05 gen 1984
    Consegnato il 24 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1984Registrazione di un'ipoteca

    MICRO-METALSMITHS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mag 2014Inizio dell'amministrazione
    21 ott 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    2
    DataTipo
    21 ott 2015Inizio della liquidazione
    05 ott 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Liquidatore proposto
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Liquidatore proposto
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Charles Graham John King
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds
    Praticante
    Ernst & Young Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5QR Water Lane
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0