SAY IT WITH EASE.COM LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SAY IT WITH EASE.COM LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00791110 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Church Bridge House Henry Street BB5 4EE Accrington United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FAD ENGINEERING LIMITED | 14 ott 1996 | 14 ott 1996 |
| NPK DIE SYSTEMS LIMITED | 13 feb 1990 | 13 feb 1990 |
| NORTHERN PRESS-KNIFE COMPANY LIMITED | 18 gen 1983 | 18 gen 1983 |
| NORTHERN PRESS-KNIFE CO., LIMITED | 07 feb 1964 | 07 feb 1964 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 26 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Nomina di Mr Michael Arnaouti come segretario in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 17 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mark Ashcroft come segretario in data 16 dic 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Mark Ashcroft come amministratore in data 16 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 26 mar 2021 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2020 | 1 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Philip Binns Maudsley come amministratore in data 26 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Modifica dei dettagli di Findel Plc come persona con controllo significativo il 26 lug 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2019 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2018 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Ashcroft il 02 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Binns Maudsley il 02 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Murdoch Caldwell il 01 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Findel Plc come persona con controllo significativo il 01 mar 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4th a Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE in data 01 mar 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Timothy John Kowalski come amministratore in data 05 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mark Ashcroft come amministratore in data 06 apr 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAOUTI, Michael | Segretario | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | 290653770001 | |||||||
| ARNAOUTI, Michael | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||
| CALDWELL, Stuart Murdoch | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 229000880001 | |||||
| ASHCROFT, Mark | Segretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165368860001 | |||||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Segretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | British | 14333000007 | ||||||
| HALE, Donald | Segretario | Trees House Staupes Road High Birstwith HG3 2LF Harrogate North Yorkshire | British | 75316130001 | ||||||
| ASHCROFT, Mark | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 113691350001 | |||||
| BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | 14333000007 | |||||
| CHAPMAN, Keith | Amministratore | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 143093130001 | |||||
| GRIFFITHS, William | Amministratore | 2 Grange Close Great Harwood BB6 7PE Blackburn Lancashire | British | 7827670001 | ||||||
| HINTON, Christopher David | Amministratore | Henry Street Church BB5 4EH Accrington Church Bridge House Lancashire | England | British | 68474940001 | |||||
| JOHNSON, David Anthony | Amministratore | Cold Knoll Farm Stanbury BD22 0HH Haworth West Yorkshire | United Kingdom | British | 157156750001 | |||||
| JOLLY, Patrick Edmund | Amministratore | Hill Top Farm Hill Top Lane Skipton Road, BB18 6JN Earby Lancashire | England | British | 75327660001 | |||||
| KOWALSKI, Timothy John | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | Uk | British | 153335190003 | |||||
| MAUDSLEY, Philip Binns | Amministratore | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 15967010001 | |||||
| SIDDLE, Roger William John | Amministratore | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | England | British | 46903210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SAY IT WITH EASE.COM LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Retail Group Plc | 06 apr 2016 | Henry Street BB5 4EE Accrington Church Bridge House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SAY IT WITH EASE.COM LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 21 gen 2015 Consegnato il 27 gen 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental security agreement | Creato il 28 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns an agreement being any of the existing facility agreement the new super senior credit agreement the revolving credit agreement and the ancillary facility agreements see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to the security agreement | Creato il 16 lug 2010 Consegnato il 29 lug 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge by way of legal mortgage | Creato il 10 nov 1988 Consegnato il 24 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land situate on the northerly side of heys land great harwood lancashire . and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 10 nov 1988 Consegnato il 24 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold land lying to the north of heys lane, great harwood lancashire t/no la 533312 together with all buildings & fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 16 mar 1988 Consegnato il 18 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures) heys lane, great harwood, blackburn, lancashire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 gen 1981 Consegnato il 31 gen 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H & l/h property known as land & factory & other buildings at heys lane great harwood nr. Blackburn lancaster.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 28 gen 1980 Consegnato il 31 gen 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises being on the northerly side of heys lane and the easterley side of wood street, great harwood, lanes together with all fixtures present & future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0