PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED

PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00798370
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2019

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2018

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2017

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 19 apr 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2016

    10 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2015

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2014

    14 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Harworth Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* in data 19 lug 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Martin Terence Alan Purvis come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Derek Parkin come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harworth Secretariat Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Uk Coal Secretariat Services Limited il 17 apr 2013

    1 pagineCH04

    Cessazione della carica di Simon Taylor come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Gareth Taylor il 12 dic 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 15 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 gen 2013

    Stato del capitale al 09 gen 2013

    • Capitale: GBP 1,010
    SH01

    Nomina di Colin Frederick Reed come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    177797480001
    PARKIN, Derek
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish177788390001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish174641750001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    British18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    British169990550001
    SUMMERSALL, Kevin David
    17 Forest Avenue
    NE12 9AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    17 Forest Avenue
    NE12 9AH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British48451880001
    WILSON, Christopher John
    4 The Paddock
    NE43 7PH Stocksfield
    Northumberland
    Segretario
    4 The Paddock
    NE43 7PH Stocksfield
    Northumberland
    British28089530002
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8223049
    172322000002
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish96416100003
    CALVER, Brian
    4 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HE Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    4 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HE Basingstoke
    Hampshire
    British52475850001
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Amministratore
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritish58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18761260001
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Amministratore
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritish95211330002
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    British99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Amministratore
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    British35904020001
    RHODES, Jeremy
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Harworth
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170032420001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Amministratore
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    American101195530002
    TAYLOR, Simon Gareth
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    Amministratore
    The Bent
    Curbar
    S32 3YD Hope Valley
    Robinhill
    England
    England
    EnglandBritish177290460002
    WILSON, Keith
    63 St Marys Avenue
    NE26 1TB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    63 St Marys Avenue
    NE26 1TB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British4281530001
    YOUNG, Robert
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    Amministratore
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    EnglandBritish3899280001

    PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 15 dic 1993
    Consegnato il 05 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 apr 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Brothers & Co Limited
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at holywood lane silverdale staffordshire t/n sf 236832 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north west of holywood lane, finney green leycett staffordshire t/n sf 175724 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the north of mansfield road, heath derbyshire t/n dy 154932 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to the north of holywood lane finney green, leycett staffordshire t/n sf 164308.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bank top farm silverdale staffordshire t/n sf 169360.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 apr 1989
    Consegnato il 15 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land forming part of the drive apedale, newcastle under lyme, & land N.W. of the drive apedale, newcastle under lyme. The proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 25 apr 1989
    Consegnato il 15 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land S.E. of high st. Leycett, newcastle under lyme the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 28 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 08 apr 1988
    Consegnato il 22 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, nsmplc, hallam all overseas limited, northern strip mining limited, the mining investment corporation limited, any "charging company" (as defined in the security agreement) the ship owning company (as likewise defined) or mincorps shipping & finance limited to barclays bank PLC or any other secured creditor (as likewise defined) under any financing document (as likewise defined)
    Brevi particolari
    All intellectual property rights etc (for full particulars of all property charged please refer to form M395 and attached continuation sheets thereto ref- M250). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Deed initial security package
    Creato il 22 apr 1985
    Consegnato il 09 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to barclays bank PLC as trustee under the terms of the security package as defined in the charge
    Brevi particolari
    All f/hold and l/hold property with all fixtures thereon all book and other debts floating charge over the see doc for fuller details. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 29 mar 1983
    Consegnato il 18 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18/3/83
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement sale agreement dated 18 march 83 (see doc M40 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 18 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 29 mar 1983
    Consegnato il 14 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 13 mar 83 or a master conditional sale agreement dated 18 mar 83.
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M39 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 29 mar 1983
    Consegnato il 14 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed by charge dated 18 mar 83 & a master conditional sale agreement dated 18 mar 83.
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers right title & interest in & to goods comprised in aconditional sale agreement dated 18 march 83 (see doc M38 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 29 mar 1983
    Consegnato il 13 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18.3.83 and a master conditional sale agreement dated 18.3.83
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M37).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 13 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 22 mar 1983
    Consegnato il 29 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers right title or interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18 march 83 (for full details see doc M36).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Security schedule
    Creato il 22 mar 1983
    Consegnato il 29 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master deed of charge dated 18 march 1983 and a master conditional sale agreement dated the 18 march 1983
    Brevi particolari
    Fixed charge over all buyers right title and interest in and to goods comprised in a conditional sale agreement dated 18.3.83 (for full details see doc M35).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Deed of charge
    Creato il 18 mar 1983
    Consegnato il 29 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a master conditional sale agreement dated 18 march 1983
    Brevi particolari
    First fixed charge over all the buyers right, title & interest present & future. (For full details see doc M33).
    Persone aventi diritto
    • Sumstock Limited.
    Transazioni
    • 29 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 27 apr 1981
    Consegnato il 12 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Limited
    Transazioni
    • 12 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Charge over all bookdebts
    Creato il 08 dic 1980
    Consegnato il 12 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts now or hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    PARKLANDS COLLIERY COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2013Inizio della liquidazione
    28 dic 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0